VERTEX PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVERTEX PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04463204
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gpf Lewis House
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Watford
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARCTIC EXPRESS LIMITED18 juin 200218 juin 2002

    Quels sont les derniers comptes de VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Shamir Pravinchandra Budhdeo en tant que secrétaire le 12 déc. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Shamir Pravinchandra Budhdeo en tant que directeur le 12 déc. 2018

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Joshy Mathew en tant que directeur le 08 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Amarjit Singh Hundal en tant que directeur le 01 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Photon Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mars 2018

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Unit 4 York House Wolsey Business Park Tolpits Lane Rickmansworth WD18 9BL United Kingdom à Gpf Lewis House Olds Approach Tolpits Lane Watford WD18 9AB le 06 mars 2018

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juil. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Shamir Pravinchandra Budhdeo le 24 juil. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Amarjit Singh Hundal le 24 juil. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Shamir Pravinchandra Budhdeo le 24 juil. 2017

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Joshy Mathew le 24 juil. 2017

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juil. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Symbio Serviced Offices Whiteleaf Road Hemel Hempstead HP3 9PH à Unit 4 York House Wolsey Business Park Tolpits Lane Rickmansworth WD18 9BL le 12 sept. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 août 2016

    État du capital au 03 août 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2015

    État du capital au 14 juil. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUDHDEO, Shamir Pravinchandra
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    Secrétaire
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    BritishPharmacist43407750018
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BUDHDEO, Pravin Dayalal Chakoo
    44 Paines Lane
    HA5 3DA Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    44 Paines Lane
    HA5 3DA Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector123127600001
    BUDHDEO, Sanjay
    Paines Lane
    HA5 3DA Pinner
    46
    Middlesex
    Administrateur
    Paines Lane
    HA5 3DA Pinner
    46
    Middlesex
    EnglandBritishDirector76029260003
    BUDHDEO, Shamir Pravinchandra
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    Administrateur
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector43407750047
    HUNDAL, Amarjit Singh
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    Administrateur
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector194021900001
    HUNDAL, Amarjit Singh
    19 North Drive
    HP9 1TZ Beconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    19 North Drive
    HP9 1TZ Beconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishPharmacist82772360003
    MATHEW, Joshy
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    Administrateur
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector208520280001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VERTEX PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Photon Properties Limited
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Olds Approach
    WD18 9AB Tolpits Lane
    Gpf Lewis House
    Watford
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    VERTEX PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 17 mai 2012
    Livré le 18 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 07 janv. 2010
    Livré le 13 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 13 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2008
    Livré le 19 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 nov. 2007
    Livré le 17 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    416 norwich rd ipswich. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 15 févr. 2007
    Livré le 24 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 7 curo park frogmore st albans hertfordshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 16 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 08 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals Limited & Barclay Pharmaceutical Limited
    Transactions
    • 08 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 nov. 2004
    Livré le 08 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2003
    Livré le 12 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    118 headstone road harrow middlesex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 11 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 7 curo park park street st albans hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 déc. 2002
    Livré le 24 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or intecare limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0