SUN CP TOPCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUN CP TOPCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04466962
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUN CP TOPCO LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SUN CP TOPCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUN CP TOPCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VELVETGRANGE LIMITED21 juin 200221 juin 2002

    Quels sont les derniers comptes de SUN CP TOPCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au23 avr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SUN CP TOPCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 avr. 2016

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 mars 2016

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Credit to the profit & loss acct 22/03/2016
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 23 avr. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2015

    État du capital au 25 juin 2015

    • Capital: GBP 51,558,606
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Inglett le 01 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 avr. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2014

    État du capital au 23 juin 2014

    • Capital: GBP 51,558,606
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 avr. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Peter Dalby le 17 avr. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Peter Dalby le 17 avr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 avr. 2012

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SUN CP TOPCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish83381250004
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81617110003
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Secrétaire
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Secrétaire
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secrétaire
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    British138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Secrétaire
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Administrateur
    75 Park Road
    W4 3EY London
    EnglandBritish37599910001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Administrateur
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Administrateur
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Administrateur
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Administrateur
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritish55841850004
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Administrateur
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Administrateur
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    OSMOND, Hugh
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    Administrateur
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    British6209210002
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Administrateur
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Administrateur
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritish54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Administrateur
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    Administrateur
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    British103272700001

    SUN CP TOPCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Borrower deed of charge
    Créé le 28 févr. 2012
    Livré le 20 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 20 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Intercreditor deed
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 05 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 05 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security over shares deed
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the tax covenant benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The charged portfolio meaning in relation to the company its charged shares and related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Intercreditor deed
    Créé le 14 déc. 2006
    Livré le 28 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has undertaken to the instructing agent that if an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any party of the unsecured debt; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the unsecured debt, subject to the intercreditor deed by way of payment repayment prepayment setoff netting or in any other manner or on account of the enforcement of any security document or payment under any guarantee for any of the secured debt, in each case the company shall hold the same on trust for the instructing agent and promptly pay the same and promptly pay an amount equal to that amount so discharged,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited as Security Trustee for the Secured Creditors
    Transactions
    • 28 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 déc. 2006
    Livré le 22 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 mai 2006
    Livré le 23 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 23 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juin 2005
    Livré le 24 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 24 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUN CP TOPCO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 avr. 2016Commencement of winding up
    29 mars 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0