LEGACY COMPANY SIX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEGACY COMPANY SIX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04470423
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?

    • Activités de services de systèmes de sécurité (80200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DETECTOR TECHNOLOGIES LIMITED18 févr. 200318 févr. 2003
    HALLCO 789 LIMITED26 juin 200226 juin 2002

    Quels sont les derniers comptes de LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 avr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:sec state release of liq
    4 pagesLIQ MISC

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2018

    11 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU à 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB le 16 nov. 2018

    2 pagesAD01

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    15 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2017

    10 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB England à 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU le 13 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 sept. 2016

    LRESSP

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name26 août 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Période comptable actuelle raccourcie du 15 avr. 2017 au 30 juin 2016

    1 pagesAA01

    Comptes de micro-entité établis au 15 avr. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    2 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juin 2016

    État du capital au 14 juin 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2016 au 15 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Nomination de Mr Michael James Newton en tant qu'administrateur le 09 juin 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Pauline Anne Norstrom en tant que directeur le 18 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael James Newton en tant que directeur le 19 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie en tant que directeur le 17 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helen Pamela Doroszkiewicz en tant que secrétaire le 17 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS à No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB le 12 mars 2016

    1 pagesAD01

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Michael James Newton en tant qu'administrateur le 13 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEWTON, Michael James
    Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    Administrateur
    Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    EnglandBritishDirector24712770003
    BENTLEY-BUCHANAN, Sarah
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    British135492410001
    DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    161099500001
    MCCOMBE, David Walter
    The Woodlands
    Westcott Street
    RH4 3NU Westcott
    Surrey
    Secrétaire
    The Woodlands
    Westcott Street
    RH4 3NU Westcott
    Surrey
    BritishCompany Secretary80583660001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Secrétaire
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    British75778420001
    SHUTE, Richard Carl
    Apple Tree Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Apple Tree Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager87650830001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    AIRD, Robert Frederick
    Pentlands
    Hookley Lane, Elstead
    GU8 6JB Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Pentlands
    Hookley Lane, Elstead
    GU8 6JB Godalming
    Surrey
    BritishDirector61691910005
    FINN, Andrew Patrick
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector169499300001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishManager75778420001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishManager75778420001
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector24712770003
    NEWTON, Michael James
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    BritishDirector84319290001
    NORSTROM, Pauline Anne
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector148506110001
    PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    WalesBritishDirector51578980004
    WISEBERG, Adam Harris
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector141666340001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    LEGACY COMPANY SIX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 oct. 2011
    Livré le 22 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 oct. 2011
    Livré le 21 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Michael James Newton
    Transactions
    • 21 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 10 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit of £5140.63 in an interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Delta Developments (Alton) Limited
    Transactions
    • 10 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 juin 2003
    Livré le 02 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    LEGACY COMPANY SIX LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 sept. 2016Commencement of winding up
    15 août 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Russell Stewart Cash
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0