LEGACY COMPANY SIX LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LEGACY COMPANY SIX LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04470423 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?
Adresse du siège social | 4th Floor Abbey House Booth Street M2 4AB Manchester |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 15 avr. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Dépôt d'insolvabilité Insolvency:sec state release of liq | 4 pages | LIQ MISC | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2018 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU à 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB le 16 nov. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal | 15 pages | LIQ10 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2017 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB England à 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU le 13 oct. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 15 avr. 2017 au 30 juin 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 15 avr. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 2 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2016 au 15 avr. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Michael James Newton en tant qu'administrateur le 09 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Pauline Anne Norstrom en tant que directeur le 18 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Newton en tant que directeur le 19 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie en tant que directeur le 17 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Pamela Doroszkiewicz en tant que secrétaire le 17 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS à No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB le 12 mars 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2015 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael James Newton en tant qu'administrateur le 13 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LEGACY COMPANY SIX LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWTON, Michael James | Administrateur | Abbey House Booth Street M2 4AB Manchester 4th Floor | England | British | Director | 24712770003 | ||||
BENTLEY-BUCHANAN, Sarah | Secrétaire | Strines Road Strines SK6 7GA Stockport 180 Cheshire United Kingdom | British | 135492410001 | ||||||
DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela | Secrétaire | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | 161099500001 | |||||||
MCCOMBE, David Walter | Secrétaire | The Woodlands Westcott Street RH4 3NU Westcott Surrey | British | Company Secretary | 80583660001 | |||||
MOORE, Ian Frederick | Secrétaire | 8 Westland Drive PO7 5UG Waterlooville Hampshire | British | 75778420001 | ||||||
SHUTE, Richard Carl | Secrétaire | Apple Tree Cottage Preston Road MK18 4HS Gawcott Buckinghamshire | British | General Manager | 87650830001 | |||||
HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||
AIRD, Robert Frederick | Administrateur | Pentlands Hookley Lane, Elstead GU8 6JB Godalming Surrey | British | Director | 61691910005 | |||||
FINN, Andrew Patrick | Administrateur | Treetops 241 Bramhall Moor Road SK7 5JL Hazel Grove Stockport Cheshire | England | British | Director | 169499300001 | ||||
MOORE, Ian Frederick | Administrateur | 8 Westland Drive PO7 5UG Waterlooville Hampshire | England | British | Manager | 75778420001 | ||||
MOORE, Ian Frederick | Administrateur | 8 Westland Drive PO7 5UG Waterlooville Hampshire | England | British | Manager | 75778420001 | ||||
NEWTON, Michael James | Administrateur | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | England | British | Director | 24712770003 | ||||
NEWTON, Michael James | Administrateur | Frandley House Warrington Road Antrobus CW9 6HB Northwich Cheshire | British | Director | 84319290001 | |||||
NORSTROM, Pauline Anne | Administrateur | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | England | British | Director | 148506110001 | ||||
PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh | Administrateur | Northwich Road Antrobus CW9 6JB Northwich No. 1 Thellow Heath Park Cheshire England | Wales | British | Director | 51578980004 | ||||
WISEBERG, Adam Harris | Administrateur | Tollbar Cottage Chester Road Over Tabley WA16 0PR Knutsford Cheshire | England | British | Director | 141666340001 | ||||
HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013270001 |
LEGACY COMPANY SIX LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 18 oct. 2011 Livré le 22 oct. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 18 oct. 2011 Livré le 21 oct. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 04 mai 2006 Livré le 10 mai 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The deposit of £5140.63 in an interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 juin 2003 Livré le 02 juil. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
LEGACY COMPANY SIX LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0