TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED

TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04482494
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    24 pagesAA

    Cessation de la nomination de Vincent Aziz Tchenguiz en tant que directeur le 19 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dror Pasher en tant que directeur le 19 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Payne en tant qu'administrateur le 19 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael David Watson en tant qu'administrateur le 19 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Aziz Tchenguiz le 01 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2015

    État du capital au 06 août 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    24 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2013 au 30 juin 2014

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2014

    État du capital au 30 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Aziz Tchenguiz le 08 oct. 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PAYNE, Mark Derick
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Administrateur
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    United KingdomBritishDirector163234160001
    WATSON, Michael David
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Administrateur
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    EnglandBritishChartered Accountant63440350001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Secrétaire
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Secrétaire
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FITZPATRICK, Antony Simon
    15 The Orchard Yoeman Lane
    Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    15 The Orchard Yoeman Lane
    Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishGroup Financial Accountant104975630002
    HUMPHREYS, Stephen
    1 Victoria Yard
    Fairclough Street
    E1 1PP London
    Administrateur
    1 Victoria Yard
    Fairclough Street
    E1 1PP London
    BritishCompany Director71438830002
    JAMES, Paul Frederick
    53 Lonsdale Drive
    Oakwood
    EN2 7LR Enfield
    Administrateur
    53 Lonsdale Drive
    Oakwood
    EN2 7LR Enfield
    BritishCompany Director48791500001
    KHADHOURI, Sidney Ezra
    21 Campbell Croft
    HA8 8DS Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    21 Campbell Croft
    HA8 8DS Edgware
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director22219210003
    PASHER, Dror
    Upper Grosvenor Street
    W1K 7PB London
    20
    Great Britain
    Administrateur
    Upper Grosvenor Street
    W1K 7PB London
    20
    Great Britain
    IsraelBritishProperty Developer62686040006
    TALJAARD, Desmond Louis Mildmay
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director215884620001
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Administrateur
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    United KingdomBritish,Company Director71890500005
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    10 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    TINDALL HOTELS (GENERAL PARTNER) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2007
    Livré le 07 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    In respect of any chargor, all monies due or to become due from that chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank Acting Through Its London Branch as Security Trustee for the Financeparties (Security Trustee)
    Transactions
    • 07 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of confirmation in respect of a debenture with floating charge dated 16 december 2004
    Créé le 11 juil. 2006
    Livré le 14 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A debenture with floating charge dated 1. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties (The Agent)
    Transactions
    • 14 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of confirmation in respect of a debenture with floating charge dated 16 december 2004
    Créé le 11 juil. 2006
    Livré le 14 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A debenture with floating charge dated 1. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties (The Agent)
    Transactions
    • 14 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture with floating charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest to and under all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants,warranties, representations and other documents in respect of the real property,as defined,and all rental income and disposal proceeds,insurance policies thereunder; fixed charge over all rights,title,interest and all shares owned by each holdco and monies standing to the credit of all accounts with any bank and the debts thereby; the goodwill of business,rights and claims in relation to uncalled capital,book and other debts and monetary claims due and all undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture with floating charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (acting as general partner of the partnership) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest to and under all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants,warranties, representations and other documents in respect of the real property,as defined,and all rental income and disposal proceeds,insurance policies thereunder; fixed charge over all rights,title,interest and all shares owned by each holdco and monies standing to the credit of all accounts with any bank and the debts thereby; the goodwill of business,rights and claims in relation to uncalled capital,book and other debts and monetary claims due and all undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Each of the Financeparties
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture with floating charge
    Créé le 30 août 2002
    Livré le 11 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The benefit of all right,title and interest to,in and under all agreements,contracts,deeds,licences,options,undertakings,guarantees,covenants and other documents in respect of the real property,as defined,with all buildings,fixtures and proceeds of sale thereof; all rental income and insurance policies and the hedge documents; all shares,monies standing to the credit of the control accounts,the goodwill of business,other rights and claims,all book and other debts,shares and assets; floating charge over all undertaking and assets;(i) f/hold land and buildings on south side of waddon way,croydon t/no sgl 545566; (ii) f/hold land and buildings on the east side of A6 at lockington; lt 224879; (iii) land to the north east of church st,lockington; lt 119635; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Landesbank,London Branch,as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 11 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture with floating charge
    Créé le 30 août 2002
    Livré le 10 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from tindall hotels limited partnership (the "borrower") acting by its general partner tindall hotels (general partner) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right,title and interest to and under all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants,warranties and other documents in respect of the real property,as defined,and all rental income and disposal proceeds,insurance policies thereunder; fixed charge over all rights,title,interest and all shares owned by each chargor and monies standing to the credit of all accounts with any bank and the debts thereby; the goodwill of business,rights and claims in relation to uncalled capital,book and other debts and monetary claims due and all assets; floating charge over all undertaking; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture with floating charge
    Créé le 30 août 2002
    Livré le 10 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from tindall hotels limited partnership (the "borrower") acting by its general partner tindall hotels (general partner) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right,title and interest to and under all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants,warranties and other documents in respect of the real property,as defined,and all rental income and disposal proceeds,insurance policies thereunder; fixed charge over all rights,title,interest and all shares owned by each chargor and monies standing to the credit of all accounts with any bank and the debts thereby; the goodwill of business,rights and claims in relation to uncalled capital,book and other debts and monetary claims due and all assets; floating charge over all undertaking; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0