NEVILLE HEALTH CARE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NEVILLE HEALTH CARE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04485012 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NEVILLE HEALTH CARE LIMITED ?
Adresse du siège social | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NEVILLE HEALTH CARE LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NEVILLE HEALTH CARE LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 28 mars 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 avr. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 28 mars 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour NEVILLE HEALTH CARE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Inscription de la charge 044850120015, créée le 27 janv. 2025 | 75 pages | MR01 | ||
Cessation de la nomination de Helen Baxendale en tant que directeur le 03 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2024 | 23 pages | AA | ||
legacy | 51 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Satisfaction de la charge 044850120014 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044850120013 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 044850120012 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Elizabeth Jane Phipps le 08 févr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Elizabeth Jane Phipps le 08 févr. 2024 | 1 pages | CH03 | ||
Inscription de la charge 044850120014, créée le 18 déc. 2023 | 41 pages | MR01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2023 | 27 pages | AA | ||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 044850120013, créée le 11 janv. 2023 | 37 pages | MR01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2022 | 30 pages | AA | ||
legacy | 52 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||
Qui sont les dirigeants de NEVILLE HEALTH CARE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANCOTT, Elizabeth Jane | Secrétaire | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | 245129000002 | |||||||
BLYTH, Angus John | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 271931050001 | ||||
MELTON, Steven Andrew | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Ceo | 289191220001 | ||||
PANCOTT, Elizabeth Jane | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Solicitor | 245049490002 | ||||
CLARKSON, Tracy | Secrétaire | 3 Mawfa Avenue S14 1AJ Sheffield | British | Secretary | 126509210001 | |||||
CRAIG, Euan David | Secrétaire | 31 Conduit Road S10 1EW Sheffield | British | Director | 88503230002 | |||||
QUARRINGTON, Julie | Secrétaire | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | British | Company Director | 66890990002 | |||||
BAXENDALE, Helen | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 260484140001 | ||||
CLARKSON, Tracy Jo-Anne | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 149324610001 | ||||
COLLINGE, Damian | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 161678570001 | ||||
CRAIG, Euan David | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 163014590001 | ||||
CUNNINGHAM, Guy Bradley | Administrateur | 259 Morthen Road Wickersley S66 1DY Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 95762420001 | ||||
CUNNINGHAM, Susan Dawn | Administrateur | Morthen Road Wickersley S66 1DY Rotherham 259 South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 138688520001 | ||||
DEVENPORT, Julie | Administrateur | 8 Pessall Lane Edingale B79 9JN Tamworth Staffordshire | British | Director | 106824970001 | |||||
DUKE, Trudy | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 140740470001 | ||||
DYSON, Neil | Administrateur | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | England | British | Company Director | 169560320001 | ||||
FOXALL, Kerris | Administrateur | 118 Penkhull New Road Penkhull ST4 5DG Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 81363200001 | ||||
KING, Richard | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 165897680001 | ||||
LIGHTON, Amanda | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 198772920001 | ||||
MELLA-RUA, Christine Alison | Administrateur | Old Chapel House Rowthorne Lane Glapwell S44 5QF Chesterfield Derbyshire | England | British | Director | 107869550002 | ||||
PANCOTT, David | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Cio | 245049550001 | ||||
QUARRINGTON, Julie | Administrateur | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | England | British | Company Director | 66890990002 | ||||
ROBSON, James | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Chief Transformation Officer | 245129180001 | ||||
ROWE-BEWICK, David | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 185125250001 | ||||
SANDS, Angela | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Coo | 245049560001 | ||||
STORR, Christine | Administrateur | 24 Ashdell Road Broomhill S10 3DA Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 81360770001 | |||||
STURROCK, David | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Development Director | 245049540001 | ||||
TAYLOR, Karen Vivien | Administrateur | The Farmhouse Aldham Mill Barnsley Road S73 8EG Wombwell South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 120510920001 | ||||
TAYLOR, Karen Vivien | Administrateur | The Farmhouse Aldham Mill Barnsley Road S73 8EG Wombwell South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 120510920001 | ||||
THOMAS, Lisa Jayne | Administrateur | Park Lane Burton Waters LN1 2YZ Lincoln 115 | Scotland | British | Director | 138694230001 | ||||
WATERS, Lynne | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 260483920001 | ||||
WATSON, Serena | Administrateur | Greenwood Avenue Upton WF9 1NS Pontefract 10 West Yorkshire United Kingdom | British | Director | 138688530001 | |||||
WHITEHEAD, John Henry | Administrateur | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | Chief Financial Officer | 239945630001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEVILLE HEALTH CARE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplar Holdings Ltd | 06 avr. 2016 | Kimberworth Road S61 1AJ Rotherham Ferham House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0