SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04502322 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED ?
Adresse du siège social | Second Floor Suite 2 Meridien House Clarendon Road WD17 1DS Watford |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tom Brophy en tant que secrétaire le 11 mai 2012 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wolseley Directors Limited en tant que directeur le 11 mai 2012 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Andrew Ross Smith en tant que directeur le 11 mai 2012 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ljbc Company Limited en tant qu'administrateur le 11 mai 2012 | 3 pages | AP02 | ||||||||||
Nomination de Mr Gary Alan Favell en tant qu'administrateur le 11 mai 2012 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Parkview 1220 Arlington Business Park Theale Reading RG7 4GA le 25 mai 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
legacy | 10 pages | MG01 | ||||||||||
legacy | 10 pages | MG01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alison Drew en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Tom Brophy en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Webster en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Andrew Ross Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2009 | 5 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Paul Webster le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Alison Drew le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 juil. 2008 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVELL, Gary Alan | Administrateur | Meridien House Clarendon Road WD17 1DS Watford Second Floor Suite 2 United Kingdom | England | British | Director | 107699240002 | ||||||||
LJBC COMPANY LIMITED | Administrateur | Kings Court 12 King Street LS1 2HL Leeds Walker Morris West Yorkshire United Kingdom |
| 169973610001 | ||||||||||
BROPHY, Tom | Secrétaire | Meridien House Clarendon Road WD17 1DS Watford Second Floor Suite 2 | 162246000001 | |||||||||||
DREW, Alison | Secrétaire | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading | British | 86845230002 | ||||||||||
RILEY, Derek Patrick | Secrétaire | 17 Princes Drive Oxshott KT22 0UL Leatherhead Surrey | Irish | Accountant | 2922210003 | |||||||||
WHITE, Mark Jonathan | Secrétaire | Hawthorn House 2 Wards Drive, Sarratt WD3 6AE Rickmansworth Herts | British | Solicitor | 82978250002 | |||||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secrétaire désigné | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||||||
BEER, Nico De | Administrateur | Flat J Highpoint North Hill Highgate N6 4BA London | United Kingdom | British | Accountant | 34607940003 | ||||||||
LYSAGHT MASON, Wayne Vernon | Administrateur | Fairview 21 Green End Braughing SG11 2PG Ware Hertfordshire | British | Company Director | 45878860002 | |||||||||
RILEY, Derek Patrick | Administrateur | 17 Princes Drive Oxshott KT22 0UL Leatherhead Surrey | England | Irish | Accountant | 2922210003 | ||||||||
SMITH, Robert Andrew Ross | Administrateur | Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading Parkview 1220 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 150753930001 | ||||||||
WEBSTER, Stephen Paul | Administrateur | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading | United Kingdom | British | Company Director | 40201730005 | ||||||||
WHITE, Mark Jonathan | Administrateur | Hawthorn House 2 Wards Drive, Sarratt WD3 6AE Rickmansworth Herts | England | British | Solicitor | 82978250002 | ||||||||
EVERDIRECTOR LIMITED | Administrateur désigné | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 | |||||||||||
WOLSELEY DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Parkview 1220 Arlington Business Park, Theale RG7 4GA Reading | 122185200001 |
SINCLAIR PREMISES (NO.2) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Créé le 11 mai 2012 Livré le 18 mai 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security deed of accession to a composite guarantee and debenture | Créé le 11 mai 2012 Livré le 17 mai 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to the secured finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 oct. 2002 Livré le 29 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from bathstore.com PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property k/a land and buildings on the north east side of oldbury road west bromwich. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0