MID G MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMID G MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04503990
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MID G MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe MID G MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MID G MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MID G MANAGEMENT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MID G MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2013

    6 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 août 2013 au 30 nov. 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Carole Margaret Spiegel en tant que secrétaire le 02 sept. 2013

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stephen Ronald Spiegel en tant que directeur le 02 sept. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Carole Margaret Spiegel en tant que directeur le 02 sept. 2013

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 juil. 2013

    État du capital au 31 juil. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Ronald Spiegel le 15 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Carole Margaret Spiegel le 15 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Carole Margaret Spiegel le 15 juil. 2013

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul James Spanjar le 22 mars 2013

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul James Spanjar le 04 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul James Spanjar le 04 déc. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de MID G MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPANJAR, Paul James
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    Administrateur
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    United KingdomBritishTreatment Director146776790005
    SPIEGEL, Carole Margaret
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    Secrétaire
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    BritishDirector67833220004
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    SPIEGEL, Carole Margaret
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    Administrateur
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    EnglandBritishDirector67833220005
    SPIEGEL, Stephen Ronald
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    Administrateur
    6 Poole Road
    Wimborne
    BH21 1QE Dorset
    EnglandBritishCounsellor Director83816570003
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    MID G MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 2007
    Livré le 08 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 windham mews 201-207 windham road bournemouth. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 04 août 2006
    Livré le 16 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 rebbeck road bournemouth. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 juil. 2005
    Livré le 26 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    27 east street weymouth. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 mai 2005
    Livré le 28 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    27 east street weymouth DT4 8BN. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2003
    Livré le 13 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 22 southcote road bournemouth dorset BH1 3SR. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 mars 2003
    Livré le 12 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0