THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED

THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04508367
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CDS AND HORNBY GROUP LIMITED09 janv. 200309 janv. 2003
    PLUS HOUSING GROUP LIMITED09 août 200209 août 2002

    Quels sont les derniers comptes de THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 juil. 2020

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 juil. 2019

    12 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Baltimore Buildings 13-15 Rodney Street Liverpool Merseyside L1 9EF à 82 st John Street London EC1M 4JN le 22 août 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 juil. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    10 pagesLIQ01

    Cessation de la nomination de Thomas Edward Murtha en tant que directeur le 12 mars 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    21 pagesAA

    Nomination de Mr John Kent en tant que secrétaire le 01 sept. 2017

    2 pagesAP03

    legacy

    pagesANNOTATION

    Cessation de la nomination de Frank Harasiwka en tant que secrétaire le 01 sept. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Ashley Kent en tant qu'administrateur le 31 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Claire Griffiths en tant que directeur le 31 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de George James Davies en tant que directeur le 15 mai 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Ann Hoskins en tant qu'administrateur le 19 mai 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Sir Peter Fahy en tant qu'administrateur le 19 mai 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Robert James O'malley en tant qu'administrateur le 17 mars 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    24 pagesAA

    Cessation de la nomination de Linda Minnis en tant que directeur le 15 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Barwise en tant que directeur le 15 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mervyn Jones en tant que directeur le 15 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 09 août 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KENT, John
    Heath Lane
    CH3 5SX Chester
    22
    United Kingdom
    Secrétaire
    Heath Lane
    CH3 5SX Chester
    22
    United Kingdom
    241405130001
    FAHY, Peter, Sir
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritishCeo218615150001
    GOWTHORPE, Brian John
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritishAssociate70266240001
    HOSKINS, Ann, Dr
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    United KingdomIrishMedical Practitioner122996890001
    KENT, John Ashley
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    United KingdomBritishFinance Director236201590001
    LAWLER, Robin
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritishChief Executive201038640001
    O'MALLEY, Robert James
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritishHead Of Strategic Planning139467140001
    PALMER, Sandra Louise
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4JN London
    82
    EnglandBritishConsultant Director147351690001
    CAREY, Alison Lesley
    Statham Road
    Bidston
    CH43 7XS Prenton
    2
    Wirral
    Secrétaire
    Statham Road
    Bidston
    CH43 7XS Prenton
    2
    Wirral
    BritishCompany Secretary135393860001
    COOPER, Matthew John
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    207698340001
    HARASIWKA, Frank
    13 - 15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    Merseyside
    England
    Secrétaire
    13 - 15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    Merseyside
    England
    210968710002
    JONES, Robert
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    British84381750002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARWISE, Anthony Jevon
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishFinance Director200220040001
    BOWDEN, Stephen
    1 Hollybrook Dene
    Romiley
    SK6 4ES Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    1 Hollybrook Dene
    Romiley
    SK6 4ES Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishOperations Director109826720002
    BUDDEN, Lesley Clare
    The Old Barn
    Llysgwyddfid
    LH7 4NW Trevddyn
    Flintshire
    Administrateur
    The Old Barn
    Llysgwyddfid
    LH7 4NW Trevddyn
    Flintshire
    WalesWelshManaging Director109826700001
    CONNOR, Christopher Gerard
    370 Liverpool Road
    Great Sankey
    WA5 1RU Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    370 Liverpool Road
    Great Sankey
    WA5 1RU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor47111220001
    CROSS, Vivien Margaret
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishGroup Finance Director149285360001
    DAVIES, George James
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishCouncillor169472780002
    DEEPWELL, Sasha Helen
    99 Lyndhurst Avenue
    L18 8AR Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    99 Lyndhurst Avenue
    L18 8AR Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishManaging Director - Development100031900001
    GRIFFITHS, Claire
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishManaging Director106594690001
    HARRIS, Paul Patrick
    1 Endfield Park
    L19 9BR Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    1 Endfield Park
    L19 9BR Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishManaging Director84381680001
    JONES, Mervyn
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishChief Executive78600880001
    JONES, Robert
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    Administrateur
    90 Ryburn Road
    L39 4SD Ormskirk
    Lancashire
    United KingdomBritishFinance Director84381750002
    MASON, Gary Stamford
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishRetired96986140001
    MILROY, Kim
    4 Runshaw Lane
    PR7 6AU Euxton
    Lancashire
    Administrateur
    4 Runshaw Lane
    PR7 6AU Euxton
    Lancashire
    BritishFinance Director109826710001
    MINNIS, Linda
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishChief Executive74216060003
    MORRIS, David Roger
    4 St Annes Road
    Aigburth
    L17 6BW Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    4 St Annes Road
    Aigburth
    L17 6BW Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishCharitable Trust Manager6484880001
    MURDEN, Gerard Francis
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishManaging Director228375200002
    MURTHA, Thomas Edward, Dr
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Baltimore Buildings
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishRetired137402260001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Administrateur
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritishSurveyor69716360003
    PARRY, Stephen
    279 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    279 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishManaging Director10538330002
    PATTERSON, Paul
    73 South Meade
    Maghull
    L31 8EG Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    73 South Meade
    Maghull
    L31 8EG Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishManaging Director110229870001
    PERRY, Kenneth William
    Casa
    Old School House Lane, Winwick
    WA2 8SQ Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Casa
    Old School House Lane, Winwick
    WA2 8SQ Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishChief Executive84381830002
    SHAW, Peter
    Orchard Way
    Kelsall
    CW6 0PB Tarporley
    The Cottage
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Orchard Way
    Kelsall
    CW6 0PB Tarporley
    The Cottage
    Cheshire
    England
    EnglandBritishManaging Director - Finance141110430001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Plus Dane (Merseyside) Housing Association Limited
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    England
    01 juil. 2016
    13-15 Rodney Street
    L1 9EF Liverpool
    Baltimore Buildings
    England
    Non
    Forme juridiqueIndustrial And Provident Society
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCo-Operative And Community Benefit Societies Act 2014
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrementIp031012
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 07 juin 2013
    Livré le 14 juin 2013
    En cours
    Brève description
    Freehold land lying on the north side of huddersfield road, delph, oldham (title number: MAN56760). Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Homes and Communities Agency
    Transactions
    • 14 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 2011
    Livré le 27 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property at huddersfield road, delph t/no MAN56760.
    Personnes ayant droit
    • Taggart Homes Lumb Mill Delph Limited (In Administration)
    Transactions
    • 27 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 2009
    Livré le 15 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Supermarket at essington road new invention willenhall t/nos. WM473041 and WM465107 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 2009
    Livré le 15 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Supermarket at north road holywell WA350272 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 2009
    Livré le 15 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Supermarket at new road willenhall t/no. WM423682 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable, all the goodwill of the company's business, the proceeds of any insurance affecting the property, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, furniture, furnishings, equipment, tools and other goods kept at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 2007
    Livré le 03 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Beetham court and 8 pall mall liverpool f/h t/nos: MS40440 and MS276681. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 août 2007
    Livré le 17 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit d senator point hornhouse lane knowsley industrial park knowsley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • New Generation Housing Association Limited
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Greater Hornby Housing Association Limited
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cds Housing Association Limited
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 12 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H building 1 site 1 access 26 whitehall road cleckheaton kirklees t/n WYK754206. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 15 févr. 2007
    Livré le 22 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1300, lingley mere business park warrington part t/no CH531404. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 2007
    Livré le 27 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plots 395/396 & 397 carrington park battersby lane warrington cheshire and plots 227/235/236 & 237 sadlers park burslem stoke on trent staffordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 19 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a vista, st davids park, flintshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)

    THREE 60 PROPERTY INVESTORS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 juil. 2018Commencement of winding up
    19 août 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Stephen Elliot Solomons
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    practitioner
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Andrew James Pear
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    practitioner
    82 St John Street
    EC1M 4JN London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0