BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBUILDSPAN HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04510568
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Adsetts House 16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAMSARD 2561 LIMITED14 août 200214 août 2002

    Quels sont les derniers comptes de BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 03 juil. 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share capital a/c 16/06/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des détails de Sig Trading Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 janv. 2023

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 16 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 oct. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    9 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Watkins en tant qu'administrateur le 31 mars 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que secrétaire le 31 mars 2021

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que directeur le 31 mars 2021

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kulbinder Kaur Dosanjh le 22 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 16 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant qu'administrateur le 18 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que secrétaire le 18 oct. 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que directeur le 18 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que secrétaire le 18 oct. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JACKSON, Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish186473820002
    WATKINS, Andrew
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish281612300001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    263973440001
    LUNN, Vincent Paul
    11 North Court
    The Ridges
    RG40 3SJ Finchampstead
    Berkshire
    Secrétaire
    11 North Court
    The Ridges
    RG40 3SJ Finchampstead
    Berkshire
    British40359890002
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    British59480370001
    HSE SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire désigné
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    900023720001
    BOW, Christopher John
    3 Sternes Way
    CB2 5DA Stapleford
    Cambridgeshire
    Administrateur
    3 Sternes Way
    CB2 5DA Stapleford
    Cambridgeshire
    EnglandBritish9235350001
    CHIVERS, Michael John
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59555980002
    CONNELL, Alan Malcolm
    Roxwell Road
    CM1 2ND Chelmsford
    66
    Essex
    Administrateur
    Roxwell Road
    CM1 2ND Chelmsford
    66
    Essex
    EnglandBritish38286240002
    DAVIES, Gareth Wyn
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    EnglandBritish109674760001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish231199720003
    LUNN, Vincent Paul
    11 North Court
    The Ridges
    RG40 3SJ Finchampstead
    Berkshire
    Administrateur
    11 North Court
    The Ridges
    RG40 3SJ Finchampstead
    Berkshire
    British40359890002
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59480370001
    MOUNTFORD, Peter
    25 Upper Brook Street
    W1K 7QD London
    Administrateur
    25 Upper Brook Street
    W1K 7QD London
    British73940150003
    TURNER, John Edwin
    Oak Corner Cottage
    Southend Road, Woodham Mortimer
    CM9 6TG Maldon
    Essex
    Administrateur
    Oak Corner Cottage
    Southend Road, Woodham Mortimer
    CM9 6TG Maldon
    Essex
    EnglandBritish64270880002
    WILLIAMS, David
    48 Wood Lane
    Wickersley
    S66 1JX Rotherham
    "Merrymede"
    South Yorkshire
    Administrateur
    48 Wood Lane
    Wickersley
    S66 1JX Rotherham
    "Merrymede"
    South Yorkshire
    EnglandEnglish127986830001
    HSE DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Administrateur désigné
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    900023710001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    16 Europa View
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    England
    06 avr. 2016
    16 Europa View
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01451007
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BUILDSPAN HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 juin 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 oct. 2002
    Livré le 10 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2561 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 10 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between the company (formerly known as hamsard 2561 limited) and stramongate assets PLC (the investor)
    Créé le 02 oct. 2002
    Livré le 15 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Stramongate Assets PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0