JOHNSON WALKER (NW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJOHNSON WALKER (NW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04512851
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JOHNSON WALKER (NW) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe JOHNSON WALKER (NW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5-7 New Road, Radcliffe
    Manchester
    M26 1LS Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de JOHNSON WALKER (NW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JOHNSON WALKER (NW) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour JOHNSON WALKER (NW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2014

    État du capital au 17 sept. 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 nov. 2013

    État du capital au 01 nov. 2013

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2012

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Brian Walker le 16 août 2012

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Johnson le 16 août 2012

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2011

    6 pagesAA

    Comptes modifiés jusqu'au 31 août 2010

    11 pagesAAMD

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 août 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    4 pages363a

    Statuts

    17 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Ordinary share holders relenquish voting rights 08/02/2008
    RES13

    Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2007

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de JOHNSON WALKER (NW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALKER, Brian
    11d Olney Street
    HD7 5EG Slaithwaite
    Chapel House
    Secrétaire
    11d Olney Street
    HD7 5EG Slaithwaite
    Chapel House
    British139933690001
    JOHNSON, Ian
    29 Colne View
    Slaithwaite
    HD7 5ET Huddersfield
    Administrateur
    29 Colne View
    Slaithwaite
    HD7 5ET Huddersfield
    EnglandBritish84068370003
    WALKER, Brian
    11d Olney Street
    HD7 5EG Slaithwaite
    Chapel House
    Administrateur
    11d Olney Street
    HD7 5EG Slaithwaite
    Chapel House
    United KingdomBritish139933690001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    JOHNSON WALKER (NW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 26 oct. 2006
    Livré le 10 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at sutcliffe street pellon halifax. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander
    • Kaupthing Singer & Friedlander
    Transactions
    • 10 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 2006
    Livré le 31 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander LTD
    Transactions
    • 31 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mai 2006
    Livré le 11 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of mount terrace pellon halifax t/n WYK180783,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 2006
    Livré le 29 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at carlisle street and west side of new street, pellon, halifax t/n's WYK767644, WYK49980 and WYK741298. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage land and buildings on the south east of olney street slaithwaite huddersfield west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0