LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOTHIAN FIFTY (151) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04513207
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2014

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 févr. 2014

    7 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * 18Th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW* le 27 févr. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2012

    État du capital au 06 août 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    11 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    11 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 11Th Floor East 33 Cavendish Square London W1G 0PW* le 10 août 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2010

    14 pagesAR01

    legacy

    6 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTOFI, Christakis, Mr.
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    Secrétaire
    10 Litchfield Way
    NW11 6NJ London
    BritishFinance Director67125820002
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Administrateur
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritishSurveyor61386600003
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Administrateur
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandScottishCompany Director159708270001
    WILSON, Guy Ian Swinburn
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishSurveyor141163410001
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    BritishAccountant141163370001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Administrateur
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritishBanker73849040001
    KERR, Donald
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    Administrateur
    28 Burnbank
    EH20 9NE Straiton
    Midlothian
    BritishBanker84247450001
    SELLAR, Gillian Christine
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    112 Seaview Terrace
    EH15 2HQ Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor107180940001
    BURNESS (DIRECTORS) LIMITED
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Administrateur désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900019120001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 04 sept. 2002
    Livré le 18 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Arlbee house, greyfriars road, cardiff t/no. WA954230. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2002
    Livré le 06 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property means arlbee house greyfriars road cardiff CF10 3BQ title number WA954230. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 2002
    Livré le 06 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    LOTHIAN FIFTY (151) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2014Dissolved on
    19 févr. 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0