TRAVELZEST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRAVELZEST PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 04520457
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRAVELZEST PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TRAVELZEST PLC ?

    Adresse du siège social
    Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRAVELZEST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VFB GROUP PLC28 août 200228 août 2002

    Quels sont les derniers comptes de TRAVELZEST PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRAVELZEST PLC ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TRAVELZEST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 sept. 2014

    10 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 12 sept. 2014

    10 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 mai 2014

    10 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    34 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    11 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Farm Cottage Heath House Wedmore Somerset BS28 4UG le 12 nov. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 août 2013 sans liste des membres

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 août 2013

    État du capital au 31 août 2013

    • Capital: GBP 2,902,722.2
    SH01

    Cessation de la nomination de Jonathan Carroll en tant que directeur le 30 juil. 2013

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Thomas John Molyneux en tant que directeur le 19 avr. 2013

    2 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2012

    72 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 29/01/2012
    RES13
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor, Delta Place, 27 Bath Road Cheltenham Gloucestershire GL53 7th le 13 nov. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 août 2012 sans liste des membres

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Carroll le 06 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2011

    73 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Cessation de la nomination de James Dominic Brooke en tant que directeur le 11 avr. 2012

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Jack Fraser en tant que directeur le 26 mars 2012

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Jack Fraser en tant que directeur le 26 mars 2012

    2 pagesTM01

    legacy

    7 pagesMG01

    Nomination de Adrian Cobbold en tant qu'administrateur le 09 janv. 2012

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TRAVELZEST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Secrétaire
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    British771320001
    COBBOLD, Adrian
    Matheson Boulevard East
    Mississauga
    2350
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    Matheson Boulevard East
    Mississauga
    2350
    Ontario
    Canada
    CanadaCanada Uk166995390001
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Administrateur
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    EnglandBritish771320001
    JENKINS, Nigel John
    Old Surrey Hall
    RH19 3PR East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    Administrateur
    Old Surrey Hall
    RH19 3PR East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    EnglandBritish24257330003
    DAVIES, Dunstana Adeshola
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    British55368820001
    SCRIP SECRETARIES LIMITED
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    Secrétaire
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    74920110001
    BROOKE, James Dominic
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Uk
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Uk
    EnglandBritish156641930001
    BRUCE MITFORD, Michael John
    Welsh Newton Common
    NP25 5RR Monmouth
    Newton House
    Gwent
    Administrateur
    Welsh Newton Common
    NP25 5RR Monmouth
    Newton House
    Gwent
    United KingdomBritish84293460004
    CARROLL, Jonathan
    18 Yorkville Ave, Unit 3002
    Toronto
    Ontario M4w 3y8
    Canada
    Administrateur
    18 Yorkville Ave, Unit 3002
    Toronto
    Ontario M4w 3y8
    Canada
    CanadaCanadian119934340001
    CHRYSANTHOU, Chrysanthos Theoclis
    69 Firs Park Avenue
    Winchmore Hill
    N21 2PR London
    Administrateur
    69 Firs Park Avenue
    Winchmore Hill
    N21 2PR London
    British90764380001
    FRASER, John Jack
    Graywood Drive
    Etobicoke
    14
    Ontario M9a 1p6
    Canada
    Administrateur
    Graywood Drive
    Etobicoke
    14
    Ontario M9a 1p6
    Canada
    CanadaCanadian139187050001
    MCKINLAY, Colin Grant
    Crossways Farm
    Nettleden Road
    HP1 3DQ Nettleden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Crossways Farm
    Nettleden Road
    HP1 3DQ Nettleden
    Hertfordshire
    British112065020002
    MOLYNEUX, Mark Thomas John
    Rockfield Park
    Rockfield
    NP5 3QB Monmouth
    Gwent
    Administrateur
    Rockfield Park
    Rockfield
    NP5 3QB Monmouth
    Gwent
    British58976290002
    MOTTERSHEAD, Christopher Alan Leigh
    Theccans
    Ringshall
    HP4 1LU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Theccans
    Ringshall
    HP4 1LU Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish144988920001
    ROBB, Nishma
    Flat 13
    40 Eastcote Road
    HA5 1DH Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    Flat 13
    40 Eastcote Road
    HA5 1DH Pinner
    Middlesex
    British117867060001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74298510001
    THOMSON, Peter
    23 Fenners Lawn
    Gresham Road
    CB1 2EH Cambridge
    Administrateur
    23 Fenners Lawn
    Gresham Road
    CB1 2EH Cambridge
    British84232180001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001

    TRAVELZEST PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 20 mars 2012
    Livré le 28 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Account name barclays bank PLC re travelzest PLC mandatory prepayment account sort code: 20-65-82 account number: 13548465. account name barclays bank PLC re travelzest PLC bms cash cover sort code: 20-65-82 account number: 13483762.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal assignment of keyman policy
    Créé le 22 déc. 2009
    Livré le 30 déc. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The keyman policy being the policy of life and critical illness assurance with policy number L0193123333 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 30 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security and note pledge agreement
    Créé le 19 juin 2008
    Livré le 03 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors or any one or more of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The instruments and securities including 7,000,000 ordinary securities in travelzest canco limited, all substitutions and replacements of and increases additions, and accessionss to the property, all proceeds derived from the property, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 03 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 juin 2008
    Livré le 26 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any finance party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 26 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable charge over shares
    Créé le 14 sept. 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable charge over shares
    Créé le 08 août 2007
    Livré le 11 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable charge over shares
    Créé le 19 mars 2007
    Livré le 21 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The shares and deivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal assignment of key man policies
    Créé le 19 mars 2007
    Livré le 21 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no 012259278-5 legal & general mr c mckinley sum assured £1,000,000, policy no 012258792-6 legal & general mr cal mottershead sum assured £1,000,000 and policy no 012259283-5 legal & general mrs nishma robb sum assured £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable charge over shares
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 28 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100 ordinary shares of £1 each in wow house limited together with any stocks, shares and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable share charge
    Créé le 08 nov. 2006
    Livré le 14 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable charge over shares
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over cash deposit
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all the companys rights title interest and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Security pledge agreement
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100 common shares and all rights and claims in such securities all substitutions and replacements of increases and additions to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    TRAVELZEST PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 nov. 2013Administration started
    12 sept. 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0