THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED

THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04523451
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED ?

    • (7032) /

    Où se situe THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHOQS 426 LIMITED02 sept. 200202 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    13 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Countryside House the Drive, Great Warley Brentwood Essex CM13 3AT le 03 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 juin 2012

    LRESSP

    Nomination de Richard Stephen Cherry en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Richard Stephen Cherry en tant qu'administrateur le 01 juin 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Russell Kelley en tant que directeur le 01 juin 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 sept. 2011

    État du capital au 30 sept. 2011

    • Capital: GBP 29,784
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2010

    7 pagesAA

    Nomination de Rodrigo Neira en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robbin Herring en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2009

    7 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 26 févr. 2010

    • Capital: GBP 29,784
    2 pagesSH01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARREN, Tracy Marina
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    British132463120001
    CHERRY, Graham Stewart
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish7228590002
    CHERRY, Richard Stephen
    High Street
    Stebbing
    CM6 3SF Great Dunmow
    The Old Vicarage
    Essex
    England
    Administrateur
    High Street
    Stebbing
    CM6 3SF Great Dunmow
    The Old Vicarage
    Essex
    England
    EnglandBritish68733260002
    NEIRA, Rodrigo
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange
    Administrateur
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    The Old Exchange
    United StatesAmerican160858210001
    HOYLES, Robin Patrick
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    British34860250001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    C H REGISTRARS LIMITED
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Secrétaire
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    39694450001
    BAX, Peter Lewis
    3 Woodland Rise
    AL8 7LE Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Woodland Rise
    AL8 7LE Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish86327680001
    COXSHALL, Susan Margaret
    33 Palmers Croft
    Chelmer Village
    CM2 6SR Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    33 Palmers Croft
    Chelmer Village
    CM2 6SR Chelmsford
    Essex
    British80946740002
    HERRING, Robbin Gordon-Lennox
    Lodge Mews
    Aberdeen Park
    N5 2BD London
    2
    Administrateur
    Lodge Mews
    Aberdeen Park
    N5 2BD London
    2
    United KingdomGerman139907960001
    KELLEY, Ian Russell
    5 Fenwick Close
    Westhoughton
    BL5 2GQ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    5 Fenwick Close
    Westhoughton
    BL5 2GQ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish81216850001
    SETHI, Nishi
    3 Upsdell Avenue
    N13 6JP London
    Administrateur
    3 Upsdell Avenue
    N13 6JP London
    EnglandBritish62629070001
    WRIGHT, Martin James
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish4403900006
    WRIGHT, Martin James
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish4403900006

    THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 27 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The car parking space numbers 001-0020 (inclusive) and PS001-PS287 (inclusive) at the development k/a the edge clowes street salford being all the property comprised in a lease dated 20 november 2002. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 nov. 2002
    Livré le 02 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE EDGE RESIDENTIAL (CAR PARK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 juin 2012Commencement of winding up
    30 oct. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Louise Donna Baxter
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Wayne Macpherson
    Begbies Traynor The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    practitioner
    Begbies Traynor The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0