BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04523673 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 10th Floor, 110 Cannon Street EC4N 6EU London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew Tadeusz Kulecki Kaye le 23 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 pages | RP01AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Jennifer Elizabeth Lambkin Lambkin en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025 | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 24 déc. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Padmini Singla en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Matthew Tadeusz Kulecki Kaye en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John Taylor en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Christopher Fannin en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2024 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 41 pages | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mourant Governance Services (Uk) Limited le 09 déc. 2024 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 50 Grosvenor Hill London W1K 3QT England à 10th Floor, 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 01 avr. 2025 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael John Pegler en tant que directeur le 03 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
État du capital au 04 juil. 2024
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 12 pages | MA | ||||||||||||||
Inscription de la charge 045236730001, créée le 20 juin 2024 | 40 pages | MR01 | ||||||||||||||
Notification de Gldc Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2024 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Brixton Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOURANT GOVERNANCE SERVICES (UK) LIMITED | Secrétaire | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 10th Floor England |
| 257041080001 | ||||||||||
| KAYE, Matthew Tadeusz Kulecki | Administrateur | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 10th Floor, England | England | British | 330409360002 | |||||||||
| LAMBKIN, Jennifer Elizabeth | Administrateur | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 10th Floor, England | England | British | 308207180001 | |||||||||
| BLEASE, Elizabeth Ann | Secrétaire | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House | Other | 132060350001 | ||||||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Secrétaire | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||||||
| FOO, Julia | Secrétaire | New Burlington Place W1S 2HR London 1 United Kingdom | 289132870001 | |||||||||||
| HOWELL, Richard | Secrétaire | 36 Arterberry Road Wimbledon SW20 8AQ London Flat 7 Kilmeny House | British | 130136450001 | ||||||||||
| SILVER, Helen Frances | Secrétaire | 68 Glenwood Gardens IG2 6XU Ilford Essex | British | 120878580001 | ||||||||||
| WATTS, Nigel Anthony | Secrétaire | 32 Springfield Park North Parade RH12 2BF Horsham West Sussex | British | 6864530001 | ||||||||||
| WHALLEY, Amanda | Secrétaire | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secrétaire | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||||||
| YOUNG, Mark Lees | Secrétaire | 30 Southway Totteridge N20 8DB London | British | 85330350001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ANDREWS, Michael John | Administrateur | Elm Grove Road Ealing W5 3JJ London 14 | British | 98009700001 | ||||||||||
| ARMITAGE, Stephen Hubert | Administrateur | The Glade Kingswood KT20 6JJ Tadworth Briarwood Surrey | United Kingdom | British | 29773030001 | |||||||||
| BRIDGES, David Crawford | Administrateur | Doric House 24a Amersham Road HP13 6QU High Wycombe Doric House Buckinghamshire | England | British | 94982860001 | |||||||||
| BRIDGES, David Crawford | Administrateur | Bath Road 234 Bath Road SL1 4EE Slough 234 Berkshire England | United Kingdom | British | 94982860002 | |||||||||
| BRIDSON, Thomas Paul Ridgway | Administrateur | 8 Crafts Lane GU31 4QQ Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 87931170001 | |||||||||
| CRADDOCK, James William Aleck | Administrateur | New Burlington Place W1S 2HR London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 268304800001 | |||||||||
| DAVIES, Stuart | Administrateur | 39 Chalgrove Road OX9 3TF Thame Oxfordshire | British | 125388030001 | ||||||||||
| DAWSON, Peter Allan | Administrateur | 9 St James Close St Johns Wood NW8 7LG London | British | 64472530003 | ||||||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Administrateur | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | England | British | 90007990001 | |||||||||
| FANNIN, Andrew Christopher | Administrateur | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 10th Floor, England | Ireland | Irish | 324291540001 | |||||||||
| GIARD, Laurence Yolande | Administrateur | Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House, 15 England | France | French | 166569010001 | |||||||||
| GOOD, James Jonathan | Administrateur | Lydiard Cottage Church Road Little Gaddesden HP4 1NZ Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 99624020001 | |||||||||
| HOLLAND, Alan Michael | Administrateur | New Burlington Place W1S 2HR London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 167815240004 | |||||||||
| HOWELL, Richard | Administrateur | Flat 7 Kilmeny House 36 Arterberry Road Wimbledon SW20 8AQ London | England | British | 164790590001 | |||||||||
| KIDD, Martin Frederick | Administrateur | Gillwood Crouch Lane Winkfield SL4 4TN Windsor Berkshire | British | 107323770001 | ||||||||||
| LEE, Steven Daniel | Administrateur | 15 Stewart Road AL5 4QE Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 2839730003 | |||||||||
| OSBORN, Gareth John | Administrateur | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | England | British | 91257750004 | |||||||||
| OWEN, Steven Jonathan | Administrateur | Foxholes Farley Green GU5 9DN Albury Surrey | United Kingdom | British | 29079190002 | |||||||||
| PEGLER, Michael John | Administrateur | Grosvenor Hill W1K 3QT London 50 England | England | British | 113065790004 | |||||||||
| PETERS, Ann Octavia | Administrateur | Grosvenor Hill W1K 3QT London 50 England | England | British | 199465250001 | |||||||||
| PILSWORTH, Andrew John | Administrateur | Grosvenor Hill W1K 3QT London 50 England | England | British | 155293090003 | |||||||||
| PROCTOR, David Richard | Administrateur | New Burlington Place W1S 2HR London 1 United Kingdom | England | British | 276737450001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRIXTON (HEATHROW ESTATE) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gldc Holdings Limited | 20 juin 2024 | Grosvenor Hill W1K 3QT London 50 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Brixton Limited | 06 avr. 2016 | New Burlington Place W1S 2HR London 1 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0