SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED

SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04524297
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2021

    10 pagesLIQ03

    legacy

    5 pagesRP04CS01

    Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU le 28 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 janv. 2020

    LRESSP

    État du capital au 30 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium cancelled, amounts from reduction credited to p&l reserves 09/12/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    31 janv. 2020Clarification A second filed CS01 (Statement of capital change) was registered on 31/01/2020.

    État du capital au 03 avr. 2019

    • Capital: GBP 200
    4 pagesSH02

    Comptes annuels établis au 29 avr. 2018

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Richard Smothers en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kirk Dyson Davis en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2017

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 01 mai 2016

    17 pagesAA

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 8

    13 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 7

    11 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 6

    13 pagesMR05

    Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    BritishSecretary92581040002
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector242658700001
    BACKHOUSE, Nicholas Paul
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    Secrétaire
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    BritishFinance Director64723790002
    LUCK, Richard Nigel
    Herschel Grange
    Warfield
    RG42 6AT Bracknell
    4
    Berkshire
    Secrétaire
    Herschel Grange
    Warfield
    RG42 6AT Bracknell
    4
    Berkshire
    British61070930001
    NEWHALL NOMINEES LIMITED
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    Secrétaire
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    18182520002
    ANAND, Rooney
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77808680003
    ANGELA, Mark David
    Cockerells Hall
    Buxhall
    IP14 3DR Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Cockerells Hall
    Buxhall
    IP14 3DR Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritishDirector168009790001
    BACKHOUSE, Nicholas Paul
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    Administrateur
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    United KingdomBritishFinance Director64723790002
    BRIDGE, Timothy John Walter
    Priory Farm
    Shudy Camps
    CB1 6RE Cambridge
    Administrateur
    Priory Farm
    Shudy Camps
    CB1 6RE Cambridge
    United KingdomBritishDirector35576730001
    BRIGGS, Hugh Alexander
    Brick Kiln Cottage Farm
    Berkhamsted Common
    HP4 1PU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Brick Kiln Cottage Farm
    Berkhamsted Common
    HP4 1PU Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBanker215065730001
    BROWN, David Anthony
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Administrateur
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    United KingdomBritishDirector163139060001
    BROWN, David Anthony
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Administrateur
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    United KingdomBritishDirector163139060001
    BULL, Ian Alan
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Administrateur
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    EnglandBritishCompany Director210299090001
    DAVIS, Kirk Dyson
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Administrateur
    Westgate Brewery
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    United KingdomBritishDirector109155280002
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishAccountant97980790001
    FORRESTER, Karen Martha
    Flat 4 16 Harley Road
    Primrose Hill
    NW3 3BN London
    Administrateur
    Flat 4 16 Harley Road
    Primrose Hill
    NW3 3BN London
    EnglandBritishCompany Director77261830001
    KING, Christopher
    6 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    6 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director77423330001
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    80h Eaton Square
    SW1W 9AP London
    Administrateur
    80h Eaton Square
    SW1W 9AP London
    BritishCompany Director75831270003
    PARKER, Raymond
    Wellfield House
    82 High Street, Clayton West
    HD8 9NS Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wellfield House
    82 High Street, Clayton West
    HD8 9NS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor86304880001
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritishCeo78974110003
    PITCHER, Kieran
    5 Redlodge Gardens
    HP4 3LW Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Redlodge Gardens
    HP4 3LW Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishDirector101938970001
    SHALLOW, Michael St John
    Felsham Hall
    Felsham
    IP30 0QN Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Felsham Hall
    Felsham
    IP30 0QN Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishDirector31387250002
    UNDERWOOD, Caroline
    Turpins Manor
    20 Turpins Chase Oaklands
    AL6 0RA Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    Turpins Manor
    20 Turpins Chase Oaklands
    AL6 0RA Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector99800110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    06 avr. 2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5265451
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second supplemental deed of charge
    Créé le 30 juin 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H anchor, exebridge (house no 6402) t/no DN395581, anchor hotel, haydon bridge (house no 2935) t/no ND79581, angel hotel, catterick (house no 2936) t/no NYK121529 for details of further property charged please refer to form 395. see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Trustee (Ci) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    First supplemental borrower deed of charge
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 19 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the borrower security trustee or any other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right title and interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h property k/a acre, march, house no. 1289 t/no CB152132 and the f/h property k/a albert tavern, south norwood, house no. 7302 t/no SGL51988 and the property k/a alexandra warley house no. 3558 t/no EX437176 for further property charged please refer to the form 395, and all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 19 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Deed of charge
    Créé le 07 mars 2005
    Livré le 22 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1550 abbott redhill f/h SY641089,5350 abingdon arms wantage f/h ON245493,5220 acall estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixture,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property,the ancillary property rights, all rights,title,benefit and interest,to and under the relevant documents and the insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc (C.I) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 22 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Twelfth supplemental trust deed supplemental to the trust deed dated 29 july 1991
    Créé le 06 août 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £86,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pubco PLC and the Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Trustee)
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 27 may 1997
    Créé le 06 août 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £25,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Trustee)
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2002
    Livré le 31 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nomura International PLC (As Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries)(as Defined)
    Transactions
    • 31 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 2002
    Livré le 21 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Manor arms streatham 13 mitcham lane SW16 6LQ t/n 225730, crown eltham 11 courtyard SE9 5PR t/n 247792, jolly anglers 33 station road woodgreen N22 6UX t/n AGL87844, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Commercial Paper Inc. as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 21 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pursuant to a third supplemental debenture which supplements a debenture dated 22 may 2001 and
    Créé le 06 sept. 2002
    Acquis le 07 oct. 2002
    Livré le 14 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole of the property, undertaking and assets constituting the sapphire number 4 rental business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Commercial Paper, Inc as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 14 oct. 2002Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 23 déc. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 23 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SAPPHIRE FOOD SOUTH EAST NO.4 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 janv. 2020Commencement of winding up
    24 avr. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0