DEDMERE MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDEDMERE MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04528424
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Integrity House Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTEGRITY SOFTWARE LIMITED14 nov. 200214 nov. 2002
    BROOMCO (3025) LIMITED06 sept. 200206 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2016

    21 pagesAA

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2015 au 31 janv. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Niall Anthony Keating en tant que directeur le 23 févr. 2016

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 sept. 2015

    État du capital au 29 sept. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stewart Holness le 29 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Joseph James Hanly le 29 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Joseph James Hanly le 29 sept. 2015

    1 pagesCH03

    Certificat de changement de nom

    Company name changed integrity software LIMITED\certificate issued on 08/04/15
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    6 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 janv. 2015

    • Capital: GBP 100.00
    4 pagesSH19

    Qui sont les dirigeants de DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANLY, Joseph James
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Irish293898290001
    HANLY, Joseph James
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    EnglandIrish293898290001
    HOLNESS, Stewart George
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    EnglandBritish97855450001
    HOWELL, Mark
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Secrétaire
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Irish139936240001
    HOWELL, Mark
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Secrétaire
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Irish139936240001
    MACARI, Mario
    23 Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Secrétaire
    23 Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    British85747410001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BERGIN, John
    15 Duncarrig
    IRISH Sutton
    Dublin 13
    Ireland
    Administrateur
    15 Duncarrig
    IRISH Sutton
    Dublin 13
    Ireland
    Irish85747470001
    BUTLER, Ken
    Woodside
    41 Flemish Place
    RG42 2FG Warfield
    Berkshire
    Administrateur
    Woodside
    41 Flemish Place
    RG42 2FG Warfield
    Berkshire
    British87335180001
    DENLEY, Gareth
    1 1 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    1 1 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    British108214220001
    EPSTEIN, Ivan Michael
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Buckinghamshire
    South African93783520001
    HOWELL, Mark
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Administrateur
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    IrelandIrish139936240001
    KEATING, Niall Anthony
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    IrelandIrish189714280001
    LUCKETT, Jeremy Kimber
    Hustings House
    Carlesgill Place
    RG9 1NY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Hustings House
    Carlesgill Place
    RG9 1NY Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish112642730001
    NAGEL, Paul
    6 Loughborough Gate
    Loughborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    6 Loughborough Gate
    Loughborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish87337070001
    NAGLE, Patrick Gabriel
    Framewood Manor
    Framewood Road
    SL2 4QR Fulmer
    Bucks
    Administrateur
    Framewood Manor
    Framewood Road
    SL2 4QR Fulmer
    Bucks
    British101646030001
    NAGLE, Peter David
    44 Burkes Road
    HP9 1PN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    44 Burkes Road
    HP9 1PN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandIrish58907400003
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 sept. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'il existe une personne enregistrable en relation avec la société, mais elle ne l'a pas identifiée.

    DEDMERE MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 30 juin 2011
    Livré le 07 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares in premier software limited and the derivative assets, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 juin 2011
    Livré le 07 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 sept. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security confirmation deed
    Créé le 18 déc. 2009
    Livré le 30 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Secured sums & secured liabilities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2005
    Livré le 05 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the mezzanine finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all land. By way of fixed charge all land and other land all plant and machinery all rental and other income and all debts all securities all insurance and assurance contracts and policies all goodwill and uncalled share capital all intellectual property and the benefit of all agreements. By way of floating charge all assets which are not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Graphite Capital Management Limited (The Mezzanine Security Agent)
    Transactions
    • 05 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A charge over intellectual property
    Créé le 20 juil. 2005
    Livré le 05 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the mezzanine finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all right title interest and benefit in and to all scheduled intellectual property, all other intellectual property, royalties and each royalties account. By way of floating charge the secured assets which are not effectively subject to any fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Graphite Capital Management Limited (The Mezzanine Security Agent)
    Transactions
    • 05 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over intellectual property
    Créé le 20 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all the company's present and future right,title,interest and benfit in and to all the scheduled intellectual property and all other intellectual property and the royalties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0