CHARTERBEST LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHARTERBEST LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04530149
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHARTERBEST LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe CHARTERBEST LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Oaktree House 14 Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHARTERBEST LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CHARTERBEST LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2016 avec mises à jour

    13 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    6 pagesAA

    Demande de rétablissement administratif

    3 pagesRT01

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2016

    État du capital au 23 juin 2016

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Charles Hall en tant qu'administrateur le 23 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Charles Hall en tant que directeur le 01 juin 2016

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Jonathan Hall en tant que directeur le 13 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    5 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 13/08/2015
    RES13

    Nomination de Mr Richard Charles Hall en tant qu'administrateur le 15 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 94 High Street Newton Le Willows Merseyside WA12 9SH à Oaktree House 14 Oaktree Road Eccleston St Helens Merseyside WA10 5LH le 27 août 2015

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 avr. 2015

    État du capital au 23 avr. 2015

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michelle Hall en tant que directeur le 30 nov. 2014

    2 pagesTM01

    Nomination de Jonathan Hall en tant qu'administrateur le 01 juil. 2014

    3 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Qui sont les dirigeants de CHARTERBEST LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HALL, Michelle
    14 Oaktree House Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    Secrétaire
    14 Oaktree House Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    British125778810002
    HALL, Richard Charles
    Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Oaktree House 14
    Merseyside
    Administrateur
    Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Oaktree House 14
    Merseyside
    EnglandBritish125778770001
    HALL, Michaela
    14 Oak Tree House
    Oak Tree Road
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    Secrétaire
    14 Oak Tree House
    Oak Tree Road
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    British85111900004
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    St James's Buildings, 79 Oxford Street
    M1 6FR Manchester
    Secrétaire
    The Britannia Suite
    St James's Buildings, 79 Oxford Street
    M1 6FR Manchester
    83758610001
    FINNEY, Kim Ginette
    Lugsmore Lane
    WA10 3DL St. Helens
    86
    Merseyside
    England
    Administrateur
    Lugsmore Lane
    WA10 3DL St. Helens
    86
    Merseyside
    England
    EnglandBritish71737310001
    HALL, Jonathan
    Daresbury Road
    WA10 5DS St Helens
    30
    Merseyside
    Uk
    Administrateur
    Daresbury Road
    WA10 5DS St Helens
    30
    Merseyside
    Uk
    UkBritish193018490001
    HALL, Jonathan
    The Cottage
    Ben Lane
    L39 0HL Bickerstaffe
    Administrateur
    The Cottage
    Ben Lane
    L39 0HL Bickerstaffe
    British85111760002
    HALL, Michaela
    14 Oak Tree House
    Oak Tree Road
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    14 Oak Tree House
    Oak Tree Road
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    British85111900004
    HALL, Michelle
    94 High Street
    Newton Le Willows
    WA12 9SH Merseyside
    Administrateur
    94 High Street
    Newton Le Willows
    WA12 9SH Merseyside
    EnglandBritish191232170001
    HALL, Richard Charles
    Oak Tree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St. Helens
    14
    Merseyside
    England
    Administrateur
    Oak Tree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St. Helens
    14
    Merseyside
    England
    EnglandBritish125778770001
    HALL, Richard Charles
    94 High Street
    Newton Le Willows
    WA12 9SH Merseyside
    Administrateur
    94 High Street
    Newton Le Willows
    WA12 9SH Merseyside
    EnglandBritish125778770001
    HALL, Richard Charles
    14 Oaktree House Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    14 Oaktree House Oaktree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St Helens
    Merseyside
    EnglandBritish125778770001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Administrateur désigné
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHARTERBEST LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Richard Charles Hall
    Oak Tree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St. Helens
    Oaktree House 14
    Merseyside
    09 sept. 2016
    Oak Tree Road
    Eccleston
    WA10 5LH St. Helens
    Oaktree House 14
    Merseyside
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    CHARTERBEST LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 21 févr. 2008
    Livré le 23 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Site of earleston labour club legh street newton-le-willows by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 18 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a site of labour club newton le willows t/no ms 534801 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 18 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 39 queen street & 1-3 earls street earls town st helens merseyside t/no MS526064. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 17 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 18 green leach avenue st helens merseyside t/no MS134800. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 2006
    Livré le 14 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The elms high street newton-le-willows merseyside by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 21 juin 2006
    Livré le 07 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    94 high street newton-le-willow merseyside. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 2006
    Livré le 14 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    67 market street newton-le-willows merseyside by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2006
    Livré le 18 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    94 high street newton-le-willows merseyside. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2005
    Livré le 13 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    125 market street newton le willows merseyside. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juil. 2003
    Livré le 28 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 27 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    28 rainford road bickerstaffe west lancs with title number LA664433. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 27 juin 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    18 green leach avenue haresfinch st helens with title number MS134800. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 27 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    26 rainford road bickerstaffe west lancs. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 27 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    241 speakman road st helens merseyside WA10 6TH. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0