NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED

NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNDNA REGIONAL CENTRES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04534962
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    ARMSTRONG WATSON
    Central House 47 St Pauls Street
    LS1 2TE Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARTDEGREE LIMITED13 sept. 200213 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mars 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    8 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 30 mars 2009

    LRESEX

    legacy

    1 pages287

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2007

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TANUKU, Purnima Murthy
    17 Bradyll Court
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8AS Blackburn
    Lancashire
    Secrétaire
    17 Bradyll Court
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8AS Blackburn
    Lancashire
    British57282270001
    CARR, Sarah
    The Homestead
    Ballam Road
    FY8 4NL Lytham
    Lancashire
    Administrateur
    The Homestead
    Ballam Road
    FY8 4NL Lytham
    Lancashire
    United KingdomBritish87270620001
    MURPHY, Lynne Rosemary
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    British71399540001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CHURCHLEY, Peter Knight
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    Administrateur
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    EnglandBritish77173520001
    MURPHY, Lynne Rosemary
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    26 Mountjoy Road
    HD1 5PZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71399540001
    THOMPSON, Michael Anthony Norcott
    The Manor House
    Church Lane
    WD25 78B Aderhem
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Manor House
    Church Lane
    WD25 78B Aderhem
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8598480003
    WALKER, Karen Evelyn
    81 School Lane
    WF15 8AW Hartshead
    West Yorkshire
    Administrateur
    81 School Lane
    WF15 8AW Hartshead
    West Yorkshire
    United KingdomBritish53035820002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2005
    Livré le 14 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property being f/h land being land on the east side of rift house primary school, masefield road, hartelpool t/no CE171732; l/h land being land on the north east side of trent road, grantham t/no LL240153; l/h land being land and buildings at norwood green school, thorncliffe road, heston t/no AGL130993, for details of further properties charged please refer to form 395, first fixed equitable charge the insurances and all future easements and other rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The New Opportunities Fund
    Transactions
    • 14 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 avr. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 nov. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 nov. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal mortgage
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 20 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property at hodge hill girls school bromford lane hodge hill birmingham. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 nov. 2004
    Livré le 16 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and buildings on the ground floor and part of the first floor of library buildings, victoria square, widnes, halton. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 juin 2004
    Livré le 18 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a land at norwood green school, heston,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 18 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 avr. 2004
    Livré le 02 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and buildings at trent road grantham lincolnshire. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over agreement for lease
    Créé le 21 janv. 2004
    Livré le 23 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee all of the rights title and interest in and to the agreement dated 5 september 2003 for the development of land and buildings at norwood green school, heston, hounslow and the proposed lease of such property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 23 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 oct. 2003
    Livré le 05 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 05 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 avr. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 nov. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 nov. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal mortgage
    Créé le 13 août 2003
    Livré le 14 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at macefield road hartlepool (being the former rift house community site). By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 14 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 juil. 2003
    Livré le 29 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 avr. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 nov. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 nov. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)

    NDNA REGIONAL CENTRES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mars 2009Commencement of winding up
    09 avr. 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Christian Kienlen
    Armstrong Watson
    Central House
    LS1 2TE 47 St Paul'S Street
    Leeds
    practitioner
    Armstrong Watson
    Central House
    LS1 2TE 47 St Paul'S Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0