CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED

CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04535160
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Britannic House
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 juil. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 26 juil. 2018

    • Capital: GBP 5.50
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 045351600007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 045351600006 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 oct. 2016 au 31 oct. 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de James Robert Elton en tant que directeur le 29 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2017 au 31 oct. 2016

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Andrew Brian Jones en tant qu'administrateur le 29 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Federico Vecchioli en tant qu'administrateur le 29 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Sam Ahmed en tant que secrétaire le 29 juil. 2016

    2 pagesAP03

    Inscription de la charge 045351600007, créée le 29 juil. 2016

    66 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2016

    13 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 045351600006, créée le 26 févr. 2016

    12 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AHMED, Sam
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Britannic House
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Britannic House
    Hertfordshire
    211752900001
    JONES, Andrew Brian
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Britannic House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Britannic House
    Hertfordshire
    EnglandEnglish178066050001
    VECCHIOLI, Federico
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Britannic House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Britannic House
    Hertfordshire
    EnglandFrench158800170002
    MACKLEY, Nicholas Andrew
    32 Byng Road
    EN5 4NR Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    32 Byng Road
    EN5 4NR Barnet
    Hertfordshire
    British41554610002
    MORRIS, Nicholas Charles
    1 Montpelier Street
    SW7 1EX London
    Secrétaire
    1 Montpelier Street
    SW7 1EX London
    British72509780002
    MOUNTBATTEN, Penelope Anne Vere
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    Secrétaire
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    British48464520002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CARTER, David Jason
    Whitepightle Wood
    Sauncey Wood Lane
    AL5 5DX Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Whitepightle Wood
    Sauncey Wood Lane
    AL5 5DX Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish86113590002
    DAWSON, Andrew Laurence
    62 Chiswick Staithe
    Chiswick
    W4 3TP London
    Administrateur
    62 Chiswick Staithe
    Chiswick
    W4 3TP London
    United KingdomBritish81580750002
    ELTON, James Robert
    64 Great Suffolk Street
    SE1 0BL London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    64 Great Suffolk Street
    SE1 0BL London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish174187110001
    MCLACHLAN, Dougald Mcgregor
    7 The Firs
    Ealing
    W5 2HG London
    Administrateur
    7 The Firs
    Ealing
    W5 2HG London
    EnglandBritish68090830002
    MOUNTBATTEN, Ivar Alexander Michael, Lord
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    Administrateur
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    EnglandBritish46140520002
    MOUNTBATTEN, Penelope Anne Vere
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    Administrateur
    Bridwell Park
    Uffculme
    EX15 3BU Cullompton
    Devon
    EnglandBritish48464520002
    PERRINS, Jonathan Gilbert Francis
    2 Adavale Road
    Brookfield
    FOREIGN Brisbane
    Queensland 4069
    Australia
    Administrateur
    2 Adavale Road
    Brookfield
    FOREIGN Brisbane
    Queensland 4069
    Australia
    AustraliaAustralian53522280003
    ROWELL, Alan George
    2 102 St George Square
    Westminster
    SW1V 2HP London
    Administrateur
    2 102 St George Square
    Westminster
    SW1V 2HP London
    Australian108555360001
    ROWLEY, Thomas John Lewis
    Queensdale Road
    W11 4QS London
    2a
    Administrateur
    Queensdale Road
    W11 4QS London
    2a
    United KingdomAustralian147725130001
    WEBSTER, George Edward
    Spencer Walk
    NW3 1QZ London
    25
    Nw3 1qz
    Administrateur
    Spencer Walk
    NW3 1QZ London
    25
    Nw3 1qz
    EnglandBritish87845070001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Crown Self Storage (Exeter) Limited
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    England
    06 avr. 2016
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Cardiff
    Numéro d'enregistrement3809665
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2016
    Livré le 02 août 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The property known as unit 12, st modwen road, parkway industrial estate, plymouth registered at the land registry with title number DN585582. For details of additional properties please refer to schedule 2.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 02 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2016
    Livré le 04 mars 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Industrial Property Nominee Limited and Dunedin Industrial Property Nominee 2 Limited
    Transactions
    • 04 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2010
    Livré le 17 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from stores or any other obligor to any finance party and the parent lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2009
    Livré le 16 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 16 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 2009
    Livré le 16 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H part of land k/a unit 12 st modwen road parkway industrial estate; land at unit 12 st modwen road parkway industrial estate plymouth t/no DN492624 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 16 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 2004
    Livré le 04 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent security deposit deed
    Créé le 14 juil. 2003
    Livré le 25 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies held in the deposit account, such sum being £55,000 together with interest accrued thereon.
    Personnes ayant droit
    • Sg Hambros Trust Company Limited (As Trustee of Falcon Property Trust)
    Transactions
    • 25 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    CROWN SELF STORAGE (PLYMOUTH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 juil. 2018Commencement of winding up
    08 nov. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0