THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED

THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04537959
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    • Restaurants et cafés sans licence (56102) / Hébergement et restauration

    Où se situe THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Leonard Curtis House Elms Square, Bury New Road
    Whitefield
    M45 7TA Greater Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COUSIN PAUL LTD06 mars 201406 mars 2014
    BARON'S PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED18 sept. 200218 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Changement d'adresse du siège social de 3 Durrant Road Bournemouth Dorset BH2 6NE à Leonard Curtis House Elms Square, Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TA le 12 déc. 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 29 nov. 2022

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 045379590010 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2021

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2020

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2019

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2018

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2016

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 sept. 2015

    État du capital au 16 sept. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Inscription de la charge 045379590010, créée le 20 mai 2015

    23 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARON, Lesley Cecilia
    Clare House
    Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    Secrétaire
    Clare House
    Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    BritishFinancial Adviser85220920003
    BARON, Lesley Cecilia
    Clare House
    Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Clare House
    Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    BritishCompany Director85220920003
    BARON, Paul
    Clare House
    Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Clare House
    Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    BritishDirector Property Developer85220850003
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Lesley Cecilia Baron
    KT11 3EG Cobham
    26 Church Street
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    KT11 3EG Cobham
    26 Church Street
    Surrey
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Paul Baron
    KT11 3EG Cobham
    26 Church Street
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    KT11 3EG Cobham
    26 Church Street
    Surrey
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 mai 2015
    Livré le 20 mai 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A fixed and floating charge over all assets.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 01 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a ground floor flat 4 surbiton hill park surbiton surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 2004
    Livré le 15 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as 27 beaconsfield road new malden surrey t/n SY284021,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold being 21 grange rd,west molesey,KT8 2PR; t/no SY730783. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 2003
    Livré le 08 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a 66 heath royal putney heath london SW15 3JN t/n TGL5495. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 oct. 2003
    Livré le 18 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being 7 kemble hall keswick road putney SW15. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as 45 heath royal 59-61 putney hill london SW15 3JN t/n TGL119975. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security over a deposit account
    Créé le 15 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title and interest of the company in the monies held in any account.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    141 chertsey court clifford avenue london SW14 7BY fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE NINETEEN FIFTY FIVE CLUB LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 nov. 2022Commencement of winding up
    15 déc. 2023Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Robert Fortune
    Leonard Curtis House, Elms Square Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    practitioner
    Leonard Curtis House, Elms Square Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    Daniel Ormerod
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    practitioner
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0