WHITE CORN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHITE CORN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04542352
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHITE CORN LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WHITE CORN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHITE CORN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EWM (TOPCO) LIMITED07 nov. 200607 nov. 2006
    THE EDINBURGH WOOLLEN MILL (GROUP) LIMITED26 févr. 200326 févr. 2003
    EWM TOPCO LIMITED11 nov. 200211 nov. 2002
    INTERCEDE 1816 LIMITED23 sept. 200223 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de WHITE CORN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour WHITE CORN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pagesLIQ14

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 19 juil. 2021

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS United Kingdom à C/O Rsm Restructuring Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 04 août 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Cessation de la nomination de Carmel Leigh en tant que directeur le 30 juin 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Anthony Herring en tant que directeur le 30 juin 2021

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 045423520009 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Global House 5 Castle Street Carlisle Cumbria CA3 8SY England à 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS le 18 juin 2021

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 juin 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Daniel Philip Day en tant que directeur le 27 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lauren Sarah Day en tant que directeur le 27 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Philip Edward Day en tant que directeur le 27 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Oliver Houston en tant que directeur le 16 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Daniel Philip Day en tant qu'administrateur le 15 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Robert Jackson en tant qu'administrateur le 15 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 045423520009, créée le 24 août 2020

    19 pagesMR01

    Inscription de la charge 045423520008, créée le 17 mars 2020

    26 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 02 mars 2019

    68 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Lauren Sarah Day le 01 nov. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Lauren Sarah Day le 24 juin 2016

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Robert Neil Edmonds en tant que directeur le 07 juin 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de WHITE CORN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARRUTHERS, June
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    Secrétaire
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    British50519150001
    JACKSON, John Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Administrateur
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    WalesBritish274337670001
    SIMPSON, Stephen Robert
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    Administrateur
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Restructuring Llp 25
    United KingdomBritish166820010002
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    DAY, Daniel Philip
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Administrateur
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish226073480001
    DAY, Lauren Sarah
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Administrateur
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    WalesBritish209763710001
    DAY, Philip Edward
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Administrateur
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    SwitzerlandBritish46992150038
    EDMONDS, Robert Neil
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Administrateur
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    EnglandBritish206608930001
    GERRARD, Paul John
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    Administrateur
    Beech House
    No 1 The Woodlands
    CA8 9HZ Hayton
    Cumbria
    UkBritish159694080001
    HERRING, John Anthony
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish151442360001
    HERRING, John Anthony
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Borough Farm
    GU8 5JY Godalming
    Surrey
    EnglandBritish151442360001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Administrateur
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    HOUSTON, David Oliver
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    Administrateur
    5 Castle Street
    CA3 8SY Carlisle
    Global House
    Cumbria
    England
    ScotlandBritish75910100005
    HOUSTON, David Oliver
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    Administrateur
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    ScotlandBritish75910100005
    LEE, Kristian Brian
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    Administrateur
    Waverley Mills
    DG13 0EB Langholm
    The Edinburgh Woollen Mill Ltd
    Dumfriesshire
    Scotland
    EnglandBritish160887440001
    LEIGH, Carmel
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Fleet Place
    Farringdon
    EC4M 7WS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish104858030003
    LIGHT, David Arthur
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Lightcroft House Caldy Road
    Caldy
    CH48 1LW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish45750750003
    WHITAKER, Alec
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    Administrateur
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    EnglandBritish60593850003
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHITE CORN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    06 avr. 2016
    DG13 0EB Langholm
    Waverley Mills
    Dumfriesshire
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleScottish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc307281
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    WHITE CORN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 août 2020
    Livré le 26 août 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 26 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 juil. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 mars 2020
    Livré le 17 mars 2020
    En cours
    Brève description
    The chargor charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any other land, investments, equipment, intellectual property, goodwill, uncalled capital, authorisations, insurances it holds in relation to any security asset.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Edinburgh Woollen Mill (Group) Limited
    Transactions
    • 17 mars 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 mars 2019
    Livré le 14 mars 2019
    En cours
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 mars 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 29 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) and each bilateral lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of all trade marks charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 29 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 31 oct. 2006
    Livré le 08 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as the edinburgh wollen mill (group) limited to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 08 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 04 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 04 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Insurance assignment
    Créé le 14 mai 2003
    Livré le 16 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right title and interest present and future in and to the policies and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Insurance assignment
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 19 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policies being 5 year bassett life policy number ASL19086 in the name of philip day for the sum of £1,000,000 commencement date 01/03/03, 5 year legal & general policy number 0088395306 in the name of alec whitaker for the sum of £250,000 commencement date 01/03/03. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries
    Transactions
    • 19 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 nov. 2002
    Livré le 20 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 20 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WHITE CORN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 juil. 2021Commencement of winding up
    08 avr. 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gordon Thomson
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Damian Webb
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0