WHITE CORN LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WHITE CORN LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04542352 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WHITE CORN LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Rsm Restructuring Llp 25 Farringdon Street EC4A 4AB London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WHITE CORN LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 02 mars 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour WHITE CORN LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 15 pages | LIQ14 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS United Kingdom à C/O Rsm Restructuring Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 04 août 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 10 pages | LIQ02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Carmel Leigh en tant que directeur le 30 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Anthony Herring en tant que directeur le 30 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 045423520009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Global House 5 Castle Street Carlisle Cumbria CA3 8SY England à 1 Fleet Place Farringdon London EC4M 7WS le 18 juin 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Philip Day en tant que directeur le 27 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lauren Sarah Day en tant que directeur le 27 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Edward Day en tant que directeur le 27 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Oliver Houston en tant que directeur le 16 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Daniel Philip Day en tant qu'administrateur le 15 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Robert Jackson en tant qu'administrateur le 15 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Inscription de la charge 045423520009, créée le 24 août 2020 | 19 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 045423520008, créée le 17 mars 2020 | 26 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 02 mars 2019 | 68 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Lauren Sarah Day le 01 nov. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Lauren Sarah Day le 24 juin 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Neil Edmonds en tant que directeur le 07 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WHITE CORN LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRUTHERS, June | Secrétaire | Burnside House Maxwell Place DG13 0DY Langholm Dumfriesshire | British | 50519150001 | ||||||
| JACKSON, John Robert | Administrateur | Farringdon Street EC4A 4AB London C/O Rsm Restructuring Llp 25 | Wales | British | 274337670001 | |||||
| SIMPSON, Stephen Robert | Administrateur | Farringdon Street EC4A 4AB London C/O Rsm Restructuring Llp 25 | United Kingdom | British | 166820010002 | |||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| DAY, Daniel Philip | Administrateur | 5 Castle Street CA3 8SY Carlisle Global House Cumbria England | Wales | British | 226073480001 | |||||
| DAY, Lauren Sarah | Administrateur | 5 Castle Street CA3 8SY Carlisle Global House Cumbria England | Wales | British | 209763710001 | |||||
| DAY, Philip Edward | Administrateur | 5 Castle Street CA3 8SY Carlisle Global House Cumbria England | Switzerland | British | 46992150038 | |||||
| EDMONDS, Robert Neil | Administrateur | 5 Castle Street CA3 8SY Carlisle Global House Cumbria England | England | British | 206608930001 | |||||
| GERRARD, Paul John | Administrateur | Beech House No 1 The Woodlands CA8 9HZ Hayton Cumbria | Uk | British | 159694080001 | |||||
| HERRING, John Anthony | Administrateur | Fleet Place Farringdon EC4M 7WS London 1 United Kingdom | England | British | 151442360001 | |||||
| HERRING, John Anthony | Administrateur | Borough Farm GU8 5JY Godalming Surrey | England | British | 151442360001 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Administrateur | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| HOUSTON, David Oliver | Administrateur | 5 Castle Street CA3 8SY Carlisle Global House Cumbria England | Scotland | British | 75910100005 | |||||
| HOUSTON, David Oliver | Administrateur | 72 Royal Gardens, Sovereigns Gate Bothwell G71 8SY Glasgow | Scotland | British | 75910100005 | |||||
| LEE, Kristian Brian | Administrateur | Waverley Mills DG13 0EB Langholm The Edinburgh Woollen Mill Ltd Dumfriesshire Scotland | England | British | 160887440001 | |||||
| LEIGH, Carmel | Administrateur | Fleet Place Farringdon EC4M 7WS London 1 United Kingdom | England | British | 104858030003 | |||||
| LIGHT, David Arthur | Administrateur | Lightcroft House Caldy Road Caldy CH48 1LW Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 45750750003 | |||||
| WHITAKER, Alec | Administrateur | Batt House Crosby On Eden CA6 4RA Carlisle | England | British | 60593850003 | |||||
| MITRE DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900024450001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHITE CORN LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Edinburgh Woollen Mill (Group) Limited | 06 avr. 2016 | DG13 0EB Langholm Waverley Mills Dumfriesshire Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
WHITE CORN LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 24 août 2020 Livré le 26 août 2020 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Not applicable. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 mars 2020 Livré le 17 mars 2020 | En cours | ||
Brève description The chargor charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any other land, investments, equipment, intellectual property, goodwill, uncalled capital, authorisations, insurances it holds in relation to any security asset. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 11 mars 2019 Livré le 14 mars 2019 | En cours | ||
Brève description Not applicable. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 juil. 2011 Livré le 29 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) and each bilateral lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions (For details of all trade marks charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating security document | Créé le 31 oct. 2006 Livré le 08 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company formerly known as the edinburgh wollen mill (group) limited to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating security document | Créé le 25 févr. 2005 Livré le 04 mars 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Insurance assignment | Créé le 14 mai 2003 Livré le 16 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of its right title and interest present and future in and to the policies and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Insurance assignment | Créé le 15 avr. 2003 Livré le 19 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The policies being 5 year bassett life policy number ASL19086 in the name of philip day for the sum of £1,000,000 commencement date 01/03/03, 5 year legal & general policy number 0088395306 in the name of alec whitaker for the sum of £250,000 commencement date 01/03/03. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 15 nov. 2002 Livré le 20 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
WHITE CORN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0