PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04543484 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 47 Wates Way CR4 4HR Mitcham Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2025 | 4 pages | AA | ||
Nomination de Mr Ian Alan Tichias en tant qu'administrateur le 01 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Eric George Hutchinson en tant que directeur le 31 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024 | 4 pages | AA | ||
Modification des détails de Carclo Diagnostic Solutions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juin 2024 | 2 pages | PSC05 | ||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 24 sept. 2016 | 6 pages | RP04CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Unit 5 Silkwood Court Ossett WF5 9TP United Kingdom à 47 Wates Way Mitcham Surrey CR4 4HR le 14 juin 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Eric George Hutchinson en tant qu'administrateur le 21 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de David Michael Bedford en tant que directeur le 21 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Angela Wakes en tant que secrétaire le 20 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Lee George Westgarth en tant que directeur le 12 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 4 pages | AA | ||
Nomination de Mr David Michael Bedford en tant qu'administrateur le 14 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Franciscus Lodewijk Paulus Doorenbosch en tant que directeur le 14 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Franciscus Lodewijk Paulus Doorenbosch en tant qu'administrateur le 07 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nicholas Ian Burgess Sanders en tant que directeur le 05 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 4 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Springstone House PO Box 88 27 Dewsbury Road Ossett West Yorkshire WF5 9WS à Unit 5 Silkwood Court Ossett WF5 9TP le 17 nov. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Carclo Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 4 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICHIAS, Ian Alan | Administrateur | Wates Way CR4 4HR Mitcham 47 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 334271110001 | |||||
| COLE, Richard Andrew | Secrétaire | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire | 262190990001 | |||||||
| COOK, Eric | Secrétaire | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire United Kingdom | 158904230001 | |||||||
| OTTAWAY, Richard John | Secrétaire | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire | 197010400001 | |||||||
| RAPSON, Bernard David | Secrétaire | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | British | 3213310001 | ||||||
| ROTHERY, Darren Keith | Secrétaire | Fairview Cottage Sheffield Road Victoria HD9 7TP Holmfirth West Yorkshire | British | 81190240001 | ||||||
| WAKES, Angela | Secrétaire | Silkwood Court WF5 9TP Ossett Unit 5 United Kingdom | 263106130001 | |||||||
| HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||
| AIKMAN, Alastair Alan, Dr | Administrateur | 3 Kestrel Close Ewshot GU10 5TW Farnham Surrey | England | British | 78432370001 | |||||
| ALLEN, Gerald John, Dr | Administrateur | Beechfield 16a Old Lincoln Road NG32 3DF Caythorpe Lincolnshire | United Kingdom | British | 107851660001 | |||||
| BAINES, Julian Huw | Administrateur | Brynglas Cogan Hall Sully Road CF64 2TQ Penarth South Glamorgan | United Kingdom | British | 44965900001 | |||||
| BAINES, Julian Huw | Administrateur | Brynglas Cogan Hall Sully Road CF64 2TQ Penarth South Glamorgan | United Kingdom | British | 44965900001 | |||||
| BEDFORD, David Michael | Administrateur | Silkwood Court WF5 9TP Ossett Unit 5 United Kingdom | England | British | 302295360001 | |||||
| BOND, Damian Joseph Peter | Administrateur | 3 The Greens Todmorden Road OL13 9HJ Bacup Lancashire | England | British | 56681240003 | |||||
| BOWERS, Roderick Johnathan William, Dr | Administrateur | 1 St Marks Road SL4 3BD Windsor Berkshire | British | 86924930001 | ||||||
| BROOKSBANK, Robert James | Administrateur | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire | England | British | 68910300001 | |||||
| DOORENBOSCH, Franciscus Lodewijk Paulus | Administrateur | Silkwood Court WF5 9TP Ossett Unit 5 United Kingdom | Netherlands | Dutch | 249600450001 | |||||
| EVANS, David Eric | Administrateur | Holly Lodge,No 6 Auchenkiln Holdings Chapelton Road G67 4HA Condorrat | British | 82946970002 | ||||||
| HARDCASTLE, John Kenneth Willis | Administrateur | Ridgecote 26 Dawstone Road Heswall CH60 0BU Wirral Merseyside | England | British | 122293450001 | |||||
| HUTCHINSON, Eric George | Administrateur | Wates Way CR4 4HR Mitcham 47 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 278361460001 | |||||
| MALLEY, Christopher John | Administrateur | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire | England | British | 172027110001 | |||||
| MINTER, Steven John, Dr | Administrateur | Moorlodge Farm Oven Hill Road New Mills SK12 4QL High Peak Derbyshire | England | British | 70871580001 | |||||
| OTTAWAY, Richard John | Administrateur | 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett PO BOX 88 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 183149280001 | |||||
| RAPSON, Bernard David | Administrateur | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | England | British | 3213310001 | |||||
| RAPSON, Bernard David | Administrateur | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | England | British | 3213310001 | |||||
| REES, Lyn Dafydd | Administrateur | c/o British Biocell International Limited Ty Glas Avenue Llanishen CF14 5DX Cardiff Golden Gate Glamorgan Wales | Wales | British | 108878140002 | |||||
| SANDERS, Nicholas Ian Burgess | Administrateur | Silkwood Court WF5 9TP Ossett Unit 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 83283880002 | |||||
| THEWLIS, Matthew John | Administrateur | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire | England | British | 266339080002 | |||||
| VIGGARS, Julian George | Administrateur | 88 Whitbarrow Road WA13 9BA Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 122088920001 | |||||
| WAKES, Angela | Administrateur | PO BOX 88 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett Springstone House West Yorkshire | England | British | 265782980001 | |||||
| WARD, Patrick Nigel | Administrateur | 27 Dewsbury Road WF5 9WS Ossett PO BOX 88 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 47974270002 | |||||
| WESTGARTH, Lee George | Administrateur | Silkwood Court WF5 9TP Ossett Unit 5 United Kingdom | England | British | 262033110002 | |||||
| WILLIAMSON, Ian | Administrateur | Longmeadow 10 Edmunton Way LE15 6JE Oakham Rutland Leicester | England | British | 43077420001 | |||||
| ZAJICEK, George Thomas | Administrateur | Blebo Lodge Pitscottie KY15 5TX Cupar Fife | Scotland | British | 97822940001 | |||||
| HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013270001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PLATFORM DIAGNOSTICS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carclo Diagnostic Solutions Limited | 06 avr. 2016 | Wates Way CR4 4HR Mitcham 47 Surrey United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0