DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED

DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04544992
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BLUE STRIPE STRATEGIES (NO.1) LIMITED24 févr. 200424 févr. 2004
    DEUTSCHE FINANCE NO. 8 (UK) LIMITED25 sept. 200225 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Cessation de la nomination de Timothy Alan Maynard en tant que directeur le 26 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Timothy Alan Maynard en tant qu'administrateur le 10 janv. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mai 2012

    3 pages4.68

    Cessation de la nomination de Rajanbabu Sivanithy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Winchester House 1 Great Winchester Street EC2N 2DB le 08 juin 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 mai 2011

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 févr. 2011

    État du capital au 28 févr. 2011

    • Capital: GBP 5,100
    SH01

    Nomination de Mr Christopher Andrew John Goldsbrough en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Mcgiddy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARTLETT, Andrew William
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secrétaire
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British73852930003
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secrétaire
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish/New Zealand157900660001
    THOMAS, David Kenyon
    Fiddes Warren
    Fairoak Lane
    KT22 0TP Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Fiddes Warren
    Fairoak Lane
    KT22 0TP Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritish59397060003
    BURTON, Jennifer Sandra
    39b Butler Avenue
    HA1 4EJ West Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    39b Butler Avenue
    HA1 4EJ West Harrow
    Middlesex
    British100622570001
    FLETCHER, Edward Michael
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    Secrétaire
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    British78572640002
    BERRY, John Charles
    12 Leacroft Avenue
    SW12 8NF Balham
    London
    Administrateur
    12 Leacroft Avenue
    SW12 8NF Balham
    London
    New Zealander56358020004
    MACFARLANE, Stuart Edward
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Administrateur
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Australian125721120002
    MAYNARD, Timothy Alan
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish159592440001
    MCGIDDY, Mark Andrew
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Administrateur
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Australian114990900003
    PRESS, Matthew
    106 Ledbury Road
    W11 2AH London
    Administrateur
    106 Ledbury Road
    W11 2AH London
    Australian104610910001
    PRICE, Mark
    The Mill House Chelmsford Road
    Battlesbridge
    SS11 8TR Wickford
    Administrateur
    The Mill House Chelmsford Road
    Battlesbridge
    SS11 8TR Wickford
    United KingdomBritish117299680001
    ROUGH, Christopher
    37 Grandison Road
    SW11 6LS London
    Administrateur
    37 Grandison Road
    SW11 6LS London
    British77807760001
    SIVANITHY, Rajanbabu
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United KingdomBritish63268810003
    SIVANITHY, Rajanbabu
    22 Sedlescombe Road
    SW6 1RD London
    Administrateur
    22 Sedlescombe Road
    SW6 1RD London
    British63268810001
    THOMAS, David Kenyon
    Fiddes Warren
    Fairoak Lane
    KT22 0TP Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Fiddes Warren
    Fairoak Lane
    KT22 0TP Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritish59397060003
    VASUDEVA, Nicholas Shashi
    57 Linden Gardens
    W2 4HJ London
    Flat 1
    Administrateur
    57 Linden Gardens
    W2 4HJ London
    Flat 1
    British/Australian79508880002

    DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of security
    Créé le 01 août 2006
    Livré le 04 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge the bank account and all rights of the comany under the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch
    Transactions
    • 04 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security document
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title, interest and benefit in and to the bank account and to the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank A.G. London Branch
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    DB VANTAGE NO.3 (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 juin 2013Dissolved on
    23 mai 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0