THE EDGE 1A LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE EDGE 1A LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04554023
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE EDGE 1A LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe THE EDGE 1A LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE EDGE 1A LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour THE EDGE 1A LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    17 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 sept. 2017

    18 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 sept. 2016

    14 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Countryside House the Drive Brentwood CM13 3AT à The Old Exchange 234 Southchurch Road Southend on Sea Essex SS1 2EG le 05 nov. 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Countryside House the Drive Brentwood Essex CM13 3AT à Countryside House the Drive Brentwood CM13 3AT le 21 oct. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2015

    LRESSP

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2014

    État du capital au 28 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Richard Stephen Cherry en tant qu'administrateur le 07 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Russell Kelley en tant que directeur le 07 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 oct. 2013

    État du capital au 31 oct. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Nomination de Rodrigo Neira en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robbin Herring en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de THE EDGE 1A LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARREN, Tracy Marina
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    British132463120001
    CHERRY, Graham Stewart
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish7228590002
    CHERRY, Richard Stephen
    Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    The Old
    Essex
    Administrateur
    Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    The Old
    Essex
    United KingdomBritish68733260003
    NEIRA, Rodrigo
    Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    The Old
    Essex
    Administrateur
    Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    The Old
    Essex
    United StatesAmerican160858210001
    HOYLES, Robin Patrick
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    British34860250001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    C H REGISTRARS LIMITED
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Secrétaire
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    39694450001
    BAX, Peter Lewis
    3 Woodland Rise
    AL8 7LE Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Woodland Rise
    AL8 7LE Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish86327680001
    COXSHALL, Susan Margaret
    33 Palmers Croft
    Chelmer Village
    CM2 6SR Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    33 Palmers Croft
    Chelmer Village
    CM2 6SR Chelmsford
    Essex
    British80946740002
    HERRING, Robbin Gordon-Lennox
    Lodge Mews
    Aberdeen Park
    N5 2BD London
    2
    Administrateur
    Lodge Mews
    Aberdeen Park
    N5 2BD London
    2
    United KingdomGerman139907960001
    KELLEY, Ian Russell
    5 Fenwick Close
    Westhoughton
    BL5 2GQ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    5 Fenwick Close
    Westhoughton
    BL5 2GQ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish81216850001
    SETHI, Nishi
    3 Upsdell Avenue
    N13 6JP London
    Administrateur
    3 Upsdell Avenue
    N13 6JP London
    EnglandBritish62629070001
    WRIGHT, Martin James
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish4403900006
    WRIGHT, Martin James
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish4403900006

    THE EDGE 1A LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 21 févr. 2003
    Livré le 27 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The non-structural part of the block k/a block 1A the edge clowes street salford as described in a lease dated 20 november 2002. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 nov. 2002
    Livré le 02 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE EDGE 1A LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2015Commencement of winding up
    09 mai 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Wayne Macpherson
    Begbies Traynor The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    practitioner
    Begbies Traynor The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Lloyd Christopher Biscoe
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    practitioner
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0