CROSS KEYS HOMES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CROSS KEYS HOMES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Converti ou fermé |
| Numéro de société | 04557701 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CROSS KEYS HOMES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CROSS KEYS HOMES LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2018 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2018 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour CROSS KEYS HOMES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Forms b and z convert to rs | 2 pages | MISC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl Paul Samuel Larter le 18 sept. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Robert Orrey en tant qu'administrateur le 18 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Samantha Jane Peeroo en tant qu'administrateur le 18 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Frederick White Holdich en tant que directeur le 18 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Angus John Kennedy en tant que directeur le 18 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl Paul Samuel Larter le 06 sept. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Elizabeth Ellen Bisset le 06 sept. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2017 | 71 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Suzanne O'brien le 17 juil. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Claire Patricia Higgins le 26 avr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Ms Suzanne O'brien en tant qu'administrateur le 21 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Samuel en tant que directeur le 20 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl Paul Samuel Larter le 24 nov. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Inscription de la charge 045577010004, créée le 23 déc. 2016 | 19 pages | MR01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2016 | 86 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wayne Fitzgerald en tant que directeur le 19 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart John Bradbury en tant que directeur le 19 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Betty Diane Lamb en tant qu'administrateur le 19 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Rachel Louise Blakemore en tant qu'administrateur le 18 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl Paul Samuel Larter le 04 déc. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christine Cunningham en tant que directeur le 10 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CROSS KEYS HOMES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGGINS, Claire Patricia | Secrétaire | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | 192784270001 | |||||||
| BELL, Donald James | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | English | 66039210003 | |||||
| BISSET, Elizabeth Ellen | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 201520160001 | |||||
| BLAKEMORE, Rachel Louise | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 206678580001 | |||||
| HIGGINS, Claire Patricia | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 147171510001 | |||||
| LAMB, Betty Diane, Cllr | Administrateur | Shrewsbury Avenue PE2 7BZ Peterborough Cross Keys Homes England | Uk | British | 215163280001 | |||||
| LARTER, Carl Paul Samuel | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 130638260011 | |||||
| O'BRIEN, Suzanne | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | Irish | 176644930004 | |||||
| ORREY, Andrew Robert | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 238173050001 | |||||
| PEEROO, Samantha Jane | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 238199740001 | |||||
| LEGGETT, Michael John | Secrétaire | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | British | 213940800001 | ||||||
| PERRY, Paul James | Secrétaire | Flat 1 - 16 Notting Hill Gate Notting Hill W11 3JE London | British | 104807410001 | ||||||
| BAIN, Isobel Margaret | Administrateur | 93 Lessingham Orton Brimbles PE2 5TR Peterborough Cambridgeshire | British | 90475320001 | ||||||
| BEECHAM, Kwamena | Administrateur | 71 Caspian Way DA10 0LD Swanscombe Kent | British | 53444090002 | ||||||
| BRADBURY, Stuart John | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 181670230001 | |||||
| BROWN, Cyril | Administrateur | 66 Loxley Werrington PE4 5BW Peterborough | British | 98599550001 | ||||||
| CHALMERS, Audrey | Administrateur | 12 Swain Court PE2 9PL Peterborough Cambridgeshire | British | 10421750002 | ||||||
| CODDINGTON, Jill | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 98599580001 | |||||
| CUNNINGHAM, Christine | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 56941200001 | |||||
| FITZGERALD, Wayne | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 48900760002 | |||||
| FORDER, Ronald | Administrateur | 92 Wildlake Orton Malborne PE2 5PQ Peterborough Cambridgeshire | British | 115711240001 | ||||||
| HOLDICH, John Frederick White | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 67625840001 | |||||
| JARVIS, Jonathan Edward Madison | Administrateur | Flat 1 Mayfair Court 15 Park Hill Rise CR0 5RU Croydon | British | 65969460001 | ||||||
| KENNEDY, Angus John, Dr | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | England | British | 81502080001 | |||||
| KHAZAI, Kamran | Administrateur | 62 Park Road PE1 2YA Peterborough Apartment 47 Cambs | England | British | 132400260001 | |||||
| LANE, Stephen | Administrateur | 69 Ploverly PE4 6JX Peterborough Cambridgeshire | British | 114403720001 | ||||||
| LEE, Benjamin Lawson | Administrateur | Barn Lodge Ashton PE9 3BA Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 98599510001 | |||||
| LENTON, Paul | Administrateur | 3 Gatenby Werrington PE4 6JU Peterborough | British | 98599600001 | ||||||
| LOW, Gordon Bernard | Administrateur | Hinchcliffe Orton Goldhay PE2 5RH Peterborough 216 Cambs | British | 129980970001 | ||||||
| MCMANUS, William James | Administrateur | 18 Bramble End PE28 5QH Sawtry Cambridgeshire | British | 98599530001 | ||||||
| MERRILL, Jason Marc | Administrateur | Shrewsbury Avenue Woodston PE2 7BZ Peterborough | United Kingdom | British | 154320360002 | |||||
| MURPHY, Graham | Administrateur | 108 Crowland Road Eye PE6 7TR Peterborough Cambridgeshire | British | 96788530001 | ||||||
| MURRAY, Edward John | Administrateur | Little Northfields Barnack PE9 3DR Stamford 12 Lincolnshire | United Kingdom | British | 133352720001 | |||||
| NASH, Patricia Ann | Administrateur | 68 Barnstock Bretton PE3 8EJ Peterborough | British | 81325330001 | ||||||
| NEWTON, Harry, Cllr | Administrateur | 18 Overstone Court Westwood PE3 7JE Peterborough Cambridgeshire | British | 99641200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROSS KEYS HOMES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough City Council | 06 avr. 2016 | Bridge Street PE1 1QT Peterborough Town Hall England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
CROSS KEYS HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 23 déc. 2016 Livré le 05 janv. 2017 | En cours | ||
Brève description Property k/a 21-51 (odd) charlotte way netherton peterborough cambridgeshire t/no CB384103. Please see image for details of further property cahrged. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplementary legal charge supplemental to a debenture dated 4 october 2004 and | Créé le 11 janv. 2010 Livré le 26 janv. 2010 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 1-12 hedda drive, hampton hargate, peterborough t/n CB308603. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplementary legal charge | Créé le 17 sept. 2008 Livré le 19 sept. 2008 | En cours | Montant garanti The secured liabilities as defined in the debenture | |
Brèves mentions 354-378 (even) eagle way hampton town centre peterborough t/no. CB298943, 2-12 (even) bank avenue hampton town centre peterborough and 18 brickstead road hampton town centre peterborough t/no.CB325199 for details of further property charged please refer to form 395. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 oct. 2004 Livré le 14 oct. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to each finance party and each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h and l/h properties in the peterborough district forming the housing stock of peterborough city council and indentified in a form TP3 and various leases between peterborough city council and the company, together with all buildings and fixtures,plant and machinery, insurances, floating charge the undertaking and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0