CAYTHORPE ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAYTHORPE ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04568412
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAYTHORPE ESTATES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe CAYTHORPE ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    47 Cold Harbour
    London
    E14 9NS
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CAYTHORPE ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CAYTHORPE ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 janv. 2013

    État du capital au 30 janv. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2012 au 31 oct. 2012

    1 pagesAA01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2011

    11 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2010

    11 pagesAA

    Nomination de Daniel Skidmore en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Cheung en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Julie Anne Davey le 22 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2006

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de CAYTHORPE ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SKIDMORE, Daniel
    Marsh Wall
    E14 9FW London
    225
    United Kingdom
    Secrétaire
    Marsh Wall
    E14 9FW London
    225
    United Kingdom
    British159347270001
    DAVEY, Julie Anne
    47 Cold Harbour
    Isle Of Dogs
    E14 9NS London
    Administrateur
    47 Cold Harbour
    Isle Of Dogs
    E14 9NS London
    EnglandBritish90670660001
    ALEXANDER, Michael
    Stammers Farm, Ulting Lane
    Ulting
    CM9 6QZ Maldon
    Essex
    Secrétaire
    Stammers Farm, Ulting Lane
    Ulting
    CM9 6QZ Maldon
    Essex
    British141199110001
    BALLANTYNE, Sarah Alison
    41 Tweedy Road
    BR1 3PR Bromley
    Kent
    Secrétaire
    41 Tweedy Road
    BR1 3PR Bromley
    Kent
    British105554100001
    CHEUNG, William
    Wickham Chase
    West Wickham
    BR4 0BH Bromley
    191
    Kent
    Secrétaire
    Wickham Chase
    West Wickham
    BR4 0BH Bromley
    191
    Kent
    British134161560001
    CHIN, Jeffery Mee Poh
    173 Chase Side
    Southgate
    N14 5HE London
    Secrétaire
    173 Chase Side
    Southgate
    N14 5HE London
    British87630470001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    LAVANCHY, Kenneth
    39 Newell Road
    HP3 9PB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    39 Newell Road
    HP3 9PB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British3605180001
    RODGER, Patrick Alexander
    Flat 4 50 Lime Grove
    W12 8EA London
    Secrétaire
    Flat 4 50 Lime Grove
    W12 8EA London
    British105100820001
    YATES, Brian Albert
    8 Cotswold Drive
    Long Melford
    CO10 9LW Sudbury
    Suffolk
    Secrétaire
    8 Cotswold Drive
    Long Melford
    CO10 9LW Sudbury
    Suffolk
    British86778570001
    HERTS SECRETARIAT LIMITED
    39 Newell Road
    HP3 9PB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    39 Newell Road
    HP3 9PB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    34727510001
    ALEXANDER, Michael
    Stammers Farm, Ulting Lane
    Ulting
    CM9 6QZ Maldon
    Essex
    Administrateur
    Stammers Farm, Ulting Lane
    Ulting
    CM9 6QZ Maldon
    Essex
    EnglandBritish141199110001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Administrateur désigné
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001
    HERTS NOMINEES LIMITED
    39 Newell Road
    HP3 9PB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    39 Newell Road
    HP3 9PB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    28550960001

    CAYTHORPE ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 2004
    Livré le 14 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a premises at caythorpe heath lane, caythorpe, grantham, lincolnshire t/no LL193610. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 14 oct. 2004
    Livré le 18 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings at caythorpe agricultural college caythorpe heath lane caythorpe t/no LL221174. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2004
    Livré le 18 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 16/10/2001
    Créé le 28 avr. 2003
    Livré le 07 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 31 oct. 2002
    Livré le 12 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a caythorpe school of agriculture, caythorpe, nr grantham, lincolnshire part of t/no. LL205530. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 16 october 2001
    Créé le 29 oct. 2002
    Livré le 12 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 oct. 2002
    Livré le 06 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0