CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD

CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04575157
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD ?

    Adresse du siège social
    20 Coxon Street
    Spondon
    DE21 7JG Derby
    Derbyshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2015 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2015

    État du capital au 28 oct. 2015

    • Capital: GBP 174,001
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2014

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2014

    État du capital au 28 oct. 2014

    • Capital: GBP 174,001
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2013

    État du capital au 30 oct. 2013

    • Capital: GBP 174,001
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012

    3 pagesAA

    Nomination de Mrs Leah Werjuka en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Isidor Heller en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011

    6 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor Saxon House Heritage Gate Friary Street Derby DE1 1NL* le 21 oct. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010

    6 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01

    legacy

    7 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2008

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WERJUKA, Leah
    Granville Road
    NW2 2LD London
    168
    United Kingdom
    Secrétaire
    Granville Road
    NW2 2LD London
    168
    United Kingdom
    179212550001
    WERJUKA, Abraham Isaac
    168 Granville Rd
    NW2 2LD London
    Administrateur
    168 Granville Rd
    NW2 2LD London
    United KingdomEnglish85279930001
    HELLER, Isidor
    168 Granville Road
    NW2 2LD London
    Secrétaire
    168 Granville Road
    NW2 2LD London
    British11855180003
    @UKPLC CLIENT SECRETARY LTD
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    Secrétaire désigné
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    900025730001
    HELLER, Isidor
    76 Woodlands
    NW11 9QU London
    Administrateur
    76 Woodlands
    NW11 9QU London
    Uk85368090001
    @UKPLC CLIENT DIRECTOR LTD
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    Administrateur désigné
    5, Jupiter House
    Calleva Park, Aldermaston
    RG7 8NN Reading
    900025720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Abraham Isaac Werjuka
    Hendon
    NW4 2NG London
    22 Green Lane
    06 avr. 2016
    Hendon
    NW4 2NG London
    22 Green Lane
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent charge agreement
    Créé le 25 juin 2012
    Livré le 28 juin 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All gross rents, licence fees and other monies receivable now or in the future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank LTD
    Transactions
    • 28 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Standard security executed on 3 april 2011
    Créé le 16 mai 2011
    Livré le 19 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from abraham isaac werjuka to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole that area of ground k/a shore park forming part of latheronwheel mains caithness in the county of caithness t/no. CTH2887 together with buildings and erections in and upon the said area of ground see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 19 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Standard security executed on 3 april 2011
    Créé le 16 mai 2011
    Livré le 19 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from abraham isaac werjuka to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole that area of ground extending to three hundred and thirty decimal or one thousandth parts of an acre or thereby lying on the south east side of the trunk road A9 leading from lybster to dunbeath and situated in the village of latheronwheel and county of caithness together with the dwellinghouse k/a craiglea and all other buildings and erections on the said ground see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 19 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 10 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 10 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 05/07/07 and
    Créé le 26 juin 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole that area of groun k/a shore park extending to 55.30 hectares or thereby forming part of latheronwheel mains caithness in the county of caithness. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 05/07/07 and
    Créé le 15 mars 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole that area of ground extending to three hundred and thirty decimal or one thoudsansth part of an acre or thereby lying on the south east side of the trunk road A9 leading from lybster to dunbeath and situated in the village of latheronwheel and county of caithness together with the dwelling house K.a "craiglea" and all buildings and erections therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 18 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 29TH november 2002 and
    Créé le 15 nov. 2002
    Livré le 07 déc. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Area of ground together with the property k/a "craiglea" and all other buildings erections on the south east side of the A9 leading from lybster to dunbeath situated in the village of latheronwheel and county of caithness. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0