CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED

CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04581346
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kingston Barns Bourn Road
    Kingston
    CB23 2NP Cambridge
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cristopher Robert Dyason le 01 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    5 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 sept. 2015 au 31 mars 2015

    1 pagesAA01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 400
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Collacott en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2014

    État du capital au 29 janv. 2014

    • Capital: GBP 400
    SH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 04 oct. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2012 au 30 sept. 2012

    1 pagesAA01

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Martin Jackson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DISS, Nicholas John
    4 Highfield Gate
    Fulbourn
    CB21 5HA Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    4 Highfield Gate
    Fulbourn
    CB21 5HA Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishChartered Accountant8174530002
    DISS, Nicholas John
    4 Highfield Gate
    Fulbourn
    CB21 5HA Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    4 Highfield Gate
    Fulbourn
    CB21 5HA Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishChartered Accountant8174530002
    DYASON, Cristopher Robert
    Primes Corner
    Histon
    CB24 9AG Cambridge
    2
    England
    Administrateur
    Primes Corner
    Histon
    CB24 9AG Cambridge
    2
    England
    EnglandBritishCo Director94583070002
    JACKSON, Martin
    Bourn Road
    Kingston
    CB23 2NP Cambridge
    Kingston Barns
    United Kingdom
    Administrateur
    Bourn Road
    Kingston
    CB23 2NP Cambridge
    Kingston Barns
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125461300002
    SAUNDERS, Kathleen Mary
    22 Dolls Close
    Balsham
    CB1 6EB Cambridge
    Secrétaire
    22 Dolls Close
    Balsham
    CB1 6EB Cambridge
    BritishSecretary88470580001
    SAUNDERS, Kathleen Mary
    22 Dolls Close
    Balsham
    CB1 6EB Cambridge
    Secrétaire
    22 Dolls Close
    Balsham
    CB1 6EB Cambridge
    BritishSecretary88470580001
    BRIGHTON SECRETARY LTD
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    Secrétaire désigné
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    900023320001
    COLLACOTT, Paul Arthur
    Lindenbrook 28 Brook Lane
    Coton
    CB3 7PY Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Lindenbrook 28 Brook Lane
    Coton
    CB3 7PY Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director31024240001
    JACKSON, Martin
    8 Perry Drive
    SG8 7HR Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Perry Drive
    SG8 7HR Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSurveyor125461300001
    BRIGHTON DIRECTOR LTD
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    Administrateur désigné
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    900023310001

    CITYGATE (CAMBRIDGE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2012
    Livré le 11 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land at the rear of 293 milton road cambridge t/no CB264661 by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Shadowdance Services Limited
    Transactions
    • 11 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 2008
    Livré le 18 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16 flats at 295 milton road cambridge by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mai 2008
    Livré le 20 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 févr. 2003
    Livré le 21 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of pledge over a deposit
    Créé le 13 févr. 2003
    Livré le 21 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All sums outstanding at credit of account number 6000543.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0