CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED

CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04582456
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor, Q4 The Square
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PINCO 1846 LIMITED06 nov. 200206 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2021

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2020

    2 pagesAA

    Nomination de Mrs Emma Louise Pearson en tant qu'administrateur le 15 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Kinsey en tant que directeur le 31 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Spruzen en tant que directeur le 30 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2019

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Ground Floor Q1 the Square Randalls Way Leatherhead KT22 7TW England à First Floor, Q4 the Square Randalls Way Leatherhead KT22 7TW le 24 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    17 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Terms and transactions contemplated by the documents approved 10/12/2018
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 045824560006, créée le 12 déc. 2018

    65 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 045824560005 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2018

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de The Care House Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TW à Ground Floor Q1 the Square Randalls Way Leatherhead KT22 7TW le 11 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2016

    2 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 045824560004 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FITTON, Garry John
    Halstow Road
    SE10 0LD London
    15
    United Kingdom
    Secrétaire
    Halstow Road
    SE10 0LD London
    15
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant105752760002
    FITTON, Garry John
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Administrateur
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    EnglandBritishChartered Accountant186021130001
    PEARSON, Emma Louise
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Administrateur
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    United KingdomBritishCeo259860950001
    BLACKMAN, David Roy
    6 Clarence Road
    KT12 5JU Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    6 Clarence Road
    KT12 5JU Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector88223190002
    FITTON, Garry John
    Flat 3 89 Blackheath Hill
    Greenwich
    SE10 8TJ London
    Secrétaire
    Flat 3 89 Blackheath Hill
    Greenwich
    SE10 8TJ London
    British105752760002
    FORD, Katherine Frances
    86 Surrey Grove
    SM1 3PN Sutton
    Surrey
    Secrétaire
    86 Surrey Grove
    SM1 3PN Sutton
    Surrey
    BritishGroup Operations Director88219740001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BLACKMAN, David Roy
    6 Clarence Road
    KT12 5JU Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    6 Clarence Road
    KT12 5JU Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritish88223190002
    BUCKINGHAM, William Michael
    Staffhurst Lodge Grants Lane
    Limpsfield
    RH8 0RH Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Staffhurst Lodge Grants Lane
    Limpsfield
    RH8 0RH Oxted
    Surrey
    United KingdomBritishDirector21944870001
    FORD, Katherine Frances
    86 Surrey Grove
    SM1 3PN Sutton
    Surrey
    Administrateur
    86 Surrey Grove
    SM1 3PN Sutton
    Surrey
    BritishGroup Operations Director88219740001
    HARLAND, David Nicholas
    11 Chy Pons
    PL25 5DH St Austell
    Cornwall
    Administrateur
    11 Chy Pons
    PL25 5DH St Austell
    Cornwall
    EnglandBritishAccountant122388960001
    KINSEY, Peter
    Thorndon
    Cowfold
    RH13 8AF Horsham
    24
    West Sussex
    Administrateur
    Thorndon
    Cowfold
    RH13 8AF Horsham
    24
    West Sussex
    EnglandBritishDirector121626760001
    MALLIKAARATCHI, Hijaya Suramya Kumara
    16 Willow Way
    KT19 0EH Ewell
    Surrey
    Administrateur
    16 Willow Way
    KT19 0EH Ewell
    Surrey
    BritishDirector Of Training88222420001
    MARSON, Rebecca Lucy
    130 Durham Road
    West Wimbledon
    SW20 0DG London
    Administrateur
    130 Durham Road
    West Wimbledon
    SW20 0DG London
    BritishDirector88222560006
    PERRY, Roland Robert Joseph
    Race Farm Lane
    Kingston
    OX13 5AY Bagpuize
    Race Farm
    Oxfordshire
    Administrateur
    Race Farm Lane
    Kingston
    OX13 5AY Bagpuize
    Race Farm
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector139021390001
    SPRUZEN, David Andrew
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    Administrateur
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    First Floor, Q4 The Square
    England
    EnglandBritishCeo110080200001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Care Management Group Uk Limited
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    England
    06 avr. 2016
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    The Care House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Cardiff
    Numéro d'enregistrement04582476
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CARE MANAGEMENT GROUP (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 déc. 2018
    Livré le 13 déc. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbc Europe Limited
    Transactions
    • 13 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 déc. 2015
    Livré le 15 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee (Registered in Scotland with Number SC090312)
    Transactions
    • 15 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 déc. 2013
    Livré le 12 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Ag, Filiale Luxemburg (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transactions
    • 12 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 29 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Green lane 179 green lane morden surrey t/no SGL290513,croydon road 52 croydon road penge london t/no SGL299112,florence avenue 43 florence avenue morden surrey t/no's SY1711833 and SGL86453 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag Niederlassung Luxemberg as Security Trustee
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 mars 2003
    Livré le 15 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any member of the group to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Security Beneficiaries
    Transactions
    • 15 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture made between (1) the company, (2) pinco 1846 limited, (3) care management group limited, (4) care management group (southern) limited (together the charging companies and each a charging company and (5) isis equity partners PLC (the security trustee)
    Créé le 10 mars 2003
    Livré le 14 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any group company to the security trustee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Isis Equity Partners PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 14 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0