TLLC DEVCO1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTLLC DEVCO1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04588941
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TLLC DEVCO1 LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe TLLC DEVCO1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TLLC DEVCO1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VIOLETDRIVE LIMITED13 nov. 200213 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de TLLC DEVCO1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour TLLC DEVCO1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    18 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re sect 175 12/03/2010
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Guy Paul Cuthbert Parsons le 03 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Victor Harvey le 03 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Grant David Hearn le 03 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jon William Mortimore le 03 févr. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jon William Mortimore le 03 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2009

    État du capital au 03 déc. 2009

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    2 pages403a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    8 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    10 pages395

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de TLLC DEVCO1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Secrétaire
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    British93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Administrateur
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish116809270002
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Administrateur
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish88628480002
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Administrateur
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Administrateur
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish102187770002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secrétaire
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Administrateur
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Administrateur
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    TLLC DEVCO1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 nov. 2006
    Livré le 18 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 18 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental leverage debenture
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 12 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor or other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in the development agreement between travelodge services limited and the chargor and the building contract between travelodge services limited and try construction limited in relation to the development. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 12 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental development debenture (relating to a development debenture dated 4 february 2003)
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 12 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor or any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the development agreement and the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security for Itself and the Other Secured Parties)
    Transactions
    • 12 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0