TLLC BRIDGECO10 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTLLC BRIDGECO10 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04589588
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TLLC BRIDGECO10 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TLLC BRIDGECO10 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TLLC BRIDGECO10 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOXCROFT LIMITED13 nov. 200213 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de TLLC BRIDGECO10 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour TLLC BRIDGECO10 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 avr. 2016

    15 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ à Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL le 04 nov. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 27 avr. 2015

    LRESEX

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2014

    État du capital au 03 déc. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 nov. 2013

    État du capital au 05 nov. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 17 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy James Evans le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de TLLC BRIDGECO10 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Australian57113450003
    EVANS, Timothy James
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritish104934670002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritish6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secrétaire
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Secrétaire
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    British93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HARVEY, Paul Victor
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    Administrateur
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    United KingdomBritish116809270002
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Administrateur
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Administrateur
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Administrateur
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    Administrateur
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    United KingdomBritish102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STOREY, Mark
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British121960950001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Administrateur
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    TLLC BRIDGECO10 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of rents
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 12 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assignor's entire right,title and interest in the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/06/2007 and
    Créé le 22 mai 2007
    Livré le 21 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H service area A1 old craighall musselburgh t/no MID43086.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 22 mai 2007
    Livré le 11 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transactions
    • 11 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Assignation of rents dated 1 december 2006 and intimation dated
    Créé le 07 déc. 2006
    Livré le 20 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The rental income payable under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transactions
    • 20 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 13 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that property situated at harrow place london l/h t/n NGL636402 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The "Security Agent")
    Transactions
    • 13 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 5 december 2006
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 13 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H subjects k/a and forming the travelodge musselburgh service area, A1, old craighall, musselburgh t/no MID43086.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transactions
    • 13 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 nov. 2006
    Livré le 18 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 18 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental leverage debenture relating to the original debenture
    Créé le 06 oct. 2003
    Livré le 18 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property being :-leasehold land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. 2) leasehold land consisting of the travelodge and little chef situated at the A1 northbound, new fox, south witham. 3) l/h land at shrewsbury road, mile end services, owestry, t/n SL47567.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotand PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transactions
    • 18 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental term debenture relating to the original debenture
    Créé le 06 oct. 2003
    Livré le 18 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any finance party. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property being the l/h land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. L/h land the travelodge & little chef at A1 northbound, new fox, south witham, colsterworth. L/h land at shrewsbury road, mile end services, oswestry t/n SL47567.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transactions
    • 18 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Créé le 01 oct. 2003
    Livré le 21 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Créé le 01 oct. 2003
    Livré le 21 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including new fox north,south witham,lincolnshire; DY184164;derby rd,alfreton swanwick;SL47567 and mile end services,oswestry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TLLC BRIDGECO10 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 avr. 2015Commencement of winding up
    06 déc. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Neil David Gostelow
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0