XPERT GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéXPERT GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04590730
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de XPERT GROUP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe XPERT GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Third Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de XPERT GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HS142 LIMITED14 nov. 200214 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de XPERT GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour XPERT GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Newton House Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 0WZ à Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN le 09 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Anthony Charles Weaver en tant que directeur le 31 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Spencer Neal Dredge en tant que directeur le 31 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2014

    État du capital au 16 déc. 2014

    • Capital: GBP 8,376,935.293058
    SH01

    Nomination de Mr Haywood Chapman en tant qu'administrateur le 01 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Spencer Neal Dredge en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Hallett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 déc. 2013

    État du capital au 04 déc. 2013

    • Capital: GBP 8,376,935.293058
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Harvey Myhill en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Peter Hayes en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Building B - Office 10 Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington Kidlington Oxfordshire OX5 3JA United Kingdom* le 17 janv. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de XPERT GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MYHILL, Paul Harvey
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    Secrétaire
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    175307470001
    CHAPMAN, Haywood Trefor
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    Administrateur
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    United KingdomBritishDirector193406100001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Secrétaire
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    BritishChief Executive Director82233550001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164935320001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    149308060001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    BritishAccountant80721980001
    HS120 LIMITED
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4JJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4JJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    84718670001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Executive Director82233550001
    BARTON, Gary Dean
    132 Hercies Road
    UB10 9ND Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    132 Hercies Road
    UB10 9ND Hillingdon
    Middlesex
    BritishDirector87769530001
    BERRY, Grant Rostron
    Bowers Croft
    32 Grove Avenue
    SK9 5EG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Bowers Croft
    32 Grove Avenue
    SK9 5EG Wilmslow
    Cheshire
    BritishVenture Capitalist70957700001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritishDirector75493580001
    COX, David Michael
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    Administrateur
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    UkBritishCompany Chairman33300110001
    CROSS, Ray John
    Dearnford Hall
    SY13 3JJ Whitchurch
    Shropshire
    Administrateur
    Dearnford Hall
    SY13 3JJ Whitchurch
    Shropshire
    UkBritishDirector42422430005
    DREDGE, Spencer Neal
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United KingdomBritishAccountant138270950001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo20621770002
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector100207880001
    RAMZAN, Mohammed
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    BritishFinance Director45096260001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant80721980001
    WEAVER, Anthony Charles
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishIt Services Consultant/Company Director153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector42686850001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector42686850001
    HEATONS DIRECTORS LIMITED
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4EN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4EN Stoke On Trent
    Staffordshire
    85624460001

    XPERT GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Group debenture
    Créé le 21 juin 2012
    Livré le 29 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 23 mars 2009
    Livré le 27 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the charged securities being name of company in which shares are held: xpert communications limited name of any nominee holder: n/a class of shares held: ordinary no. Of shares held: 299,999 of £1.00 each issued share capital: 299,999 ordinary shares of £1.00 each, name of company in which shares are held: redstone converged solutions limited name of any nominee holder: n/a class of shares held: ordinary no. Of shares held: 1,000 of £1.00 each issued share capital: 102,144 ordinary shares of £1.00 each any related rights, all dividends, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009
    • 31 mars 2009
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 2005
    Livré le 06 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 juil. 2003
    Livré le 24 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Securityholder)
    Transactions
    • 24 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2003
    Livré le 08 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 08 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Créé le 01 févr. 2003
    Livré le 05 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    XPERT GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 nov. 2016Dissolved on
    22 juin 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    practitioner
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Terence Guy Jackson
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    practitioner
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0