TLLC CMPROPCO8 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTLLC CMPROPCO8 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04592829
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TLLC CMPROPCO8 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TLLC CMPROPCO8 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TLLC CMPROPCO8 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BREWSTERHURST LIMITED18 nov. 200218 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de TLLC CMPROPCO8 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour TLLC CMPROPCO8 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    27 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 déc. 2015

    49 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ à Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD le 24 déc. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 10 déc. 2014

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    7 pages4.20

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2014

    État du capital au 09 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,200,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2013

    État du capital au 11 nov. 2013

    • Capital: GBP 1,200,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 17 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    20 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de TLLC CMPROPCO8 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Secrétaire
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Australian57113450003
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    United KingdomBritish6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secrétaire
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Secrétaire
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    British93906210001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Administrateur
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Administrateur
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Administrateur
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritish93906210001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Administrateur
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    TLLC CMPROPCO8 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Confirmatory security agreement
    Créé le 28 janv. 2010
    Livré le 04 févr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 04 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security deed
    Créé le 19 oct. 2004
    Livré le 27 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All f/h and l/h property, all buildings erections fixtures fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intercompany loans, goodwill & uncalled capital floating charge all assets not charged or assigned under the deed, all assets located in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Finance Parties(Security Agent)
    Transactions
    • 27 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 27 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The subjects known as little chef,kingsway west,dundee (0.36 hectares),county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 27 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Little chef,kingsway west,dundee (0.36 hectares),county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including lands at ludlow,shropshire,SL42880;bebington,wirral,MS298121;markham moor filling station,markham moor,nottinghamshire,NT294226. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TLLC CMPROPCO8 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 déc. 2014Commencement of winding up
    30 déc. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Neil David Gostelow
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0