TER 400 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTER 400 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04595020
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TER 400 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TER 400 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Victoria Works
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TER 400 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ICON PIECEAMBER LIMITED06 janv. 200506 janv. 2005
    ICON POLYMER GROUP LIMITED14 janv. 200314 janv. 2003
    PIECEAMBER LIMITED19 nov. 200219 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de TER 400 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TER 400 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    État du capital au 10 févr. 2012

    • Capital: GBP 0.156127
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium reduced 06/02/2012
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Denzil Pryce le 24 août 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Denzil Pryce le 15 juin 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Denzil Pryce le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de TER 400 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Secrétaire
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    British112482850001
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Administrateur
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    EnglandBritish112482850001
    PRYCE, Timothy Denzil
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish139882140005
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    British104260670001
    JOHNSON, Joanne Elizabeth
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    British86411760001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    British44240520002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAILEY, Roger Piers Marden
    Cheriton
    Pikes Hill Avenue
    SO43 7AX Lyndhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Cheriton
    Pikes Hill Avenue
    SO43 7AX Lyndhurst
    Hampshire
    British104169400001
    CALLAN, Maurice Simon
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    British72172980001
    GOGERTY, Richard Howard
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    Administrateur
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    EnglandBritish83926860003
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish104260670001
    JOHNSON, Joanne Elizabeth
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish86411760001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    SIMM, Jonathan David
    Whitenap House
    Whitenap Lane
    SO51 5RR Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Whitenap House
    Whitenap Lane
    SO51 5RR Romsey
    Hampshire
    British71817930002
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Administrateur
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    British44240520002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TER 400 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 12 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 07 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 07 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Omnibus letter of set-off
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 19 déc. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 19 déc. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 19 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 19 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0