FAWKES PHOENIX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFAWKES PHOENIX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04597339
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    King Loose & Co. St. John's House
    5 South Parade
    OX2 7JL
    OX2 7JL Summertown
    Oxford
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALBURN (SOUTH EAST) LIMITED21 nov. 200221 nov. 2002

    Quels sont les derniers comptes de FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 30 juin 2021

    6 pagesAA

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 30 juin 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes audités abrégés arrêtés au 30 juin 2019

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Markboard Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC03

    Cessation de Anne Marie Smyth en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC07

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bryan William Lawlor le 01 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Notification de Anne Marie Smyth en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O King Loose St Johns House 5 South Parade Sommertown Oxford OX2 7JL à PO Box OX2 7JL King Loose & Co. St. John's House 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL le 04 avr. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2016

    10 pagesAA

    Nomination de Alannah Smyth en tant qu'administrateur le 21 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2016

    État du capital au 28 avr. 2016

    • Capital: GBP 336,808.187222
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2015

    État du capital au 28 avr. 2015

    • Capital: GBP 336,808.187222
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2014

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2014

    État du capital au 28 avr. 2014

    • Capital: GBP 336,808.187222
    SH01

    Qui sont les dirigeants de FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMYTH, Alannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Secrétaire
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    154701650001
    KINNAIRD, Nigel John
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Administrateur
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Northern IrelandBritish83042830001
    LAWLOR, Bryan William
    Kenilworth Square
    Dublin 6
    60
    Ireland
    Administrateur
    Kenilworth Square
    Dublin 6
    60
    Ireland
    IrelandIrish154652750015
    SMYTH, Alannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Administrateur
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    IrelandIrish225157700001
    SMYTH, Noel Martin
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    Administrateur
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    IrelandIrish91238420002
    LAWLOR, Bryan William
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Secrétaire
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Irish102461750012
    MORAN, John
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Secrétaire
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Irish81598910001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Secrétaire désigné
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    900022270001
    LAWLOR, Bryan William
    Rodini
    Waterford Road
    County Kilkenny
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Rodini
    Waterford Road
    County Kilkenny
    Republic Of Ireland
    Irish102461750001
    MCKENNA, John
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish116525480001
    MORAN, John
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Administrateur
    10 Fitzwilliam Square
    Dublin
    Dublin 2
    Ireland
    Irish81598910001
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Administrateur désigné
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    900022260001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Administrateur désigné
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    900022250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FAWKES PHOENIX LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ms. Anne Marie Smyth
    Elm House
    Leopardstown Office Park
    Sandyford
    Second Floor
    Dublin 18
    Ireland
    06 avr. 2016
    Elm House
    Leopardstown Office Park
    Sandyford
    Second Floor
    Dublin 18
    Ireland
    Oui
    Nationalité: Irish
    Pays de résidence: Ireland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Markboard Limited
    St. John's House
    5 South Parade
    OX2 7JL Summertown, Oxford
    King Loose & Co.
    England
    06 avr. 2016
    St. John's House
    5 South Parade
    OX2 7JL Summertown, Oxford
    King Loose & Co.
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleUk Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    FAWKES PHOENIX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge on account
    Créé le 02 sept. 2011
    Livré le 02 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of charge and assignment the security account, the deposit and the debt. By charge on account, by way of floating charge the security account, the deposit and the debt see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 02 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 03 oct. 2007
    Livré le 06 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 06 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 04 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property known as 21-22 grosvenor street london and 21-22 brooks mews london t/n NGL806938,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 04 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    New guarantor debenture
    Créé le 04 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the borrower to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of legal charge
    Créé le 28 janv. 2003
    Livré le 01 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and alburn (commercial) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land k/a 1 old foge ind estate redditch part HW99625 and part HW188624, l/h land k/a site 3C crompton way segensworth part HP270506 and l/h land k/a units 1-3 moreton ind. Est. Swanley sevenoaks part K469003 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 01 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0