NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04611037 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?
Adresse du siège social | Southgate House Archer Street DL3 6AH Darlington County Durham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 02 nov. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2020 | 18 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 046110370006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 046110370007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 046110370008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 046110370009, créée le 27 avr. 2021 | 57 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 046110370010, créée le 27 avr. 2021 | 90 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 046110370011, créée le 27 avr. 2021 | 216 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Walter Tugendhat en tant qu'administrateur le 14 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2019 | 19 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Justin Hutchens en tant que directeur le 05 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2018 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Justin Hutchens le 08 janv. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, David Andrew, Mr. | Administrateur | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
TUGENDHAT, James Walter | Administrateur | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham | United Kingdom | British | Company Director | 218306870001 | ||||
FLETCHER, Rachel Elizabeth | Secrétaire | Flat 1 Basement 269 Magdalen Road Earlsfield SW18 3NZ London | British | 106745220001 | ||||||
GRAHAM, Annabel Susan | Secrétaire | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | Company Secretary | 108637650001 | |||||
KAUL, Sheila | Secrétaire | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | Company Secretary | 70194600001 | |||||
MIDMER, Richard Neil | Secrétaire | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | Company Director | 110640170001 | |||||
MIDMER, Richard Neil | Secrétaire | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | Company Director | 110640170001 | |||||
MORTIMER, Rachel | Secrétaire | 14 Huron Road SW17 8RB London | British | 102674500002 | ||||||
PANG, Lily | Secrétaire | Calbourne Road SW12 8LW London 9 United Kingdom | Malaysian | Group Financial Controller | 140239060001 | |||||
POOLEY, Maureen | Secrétaire désigné | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | British | 900008180001 | ||||||
AUBERY, Paul Richard | Administrateur | 1 Malthouse Drive Regency Quay Chiswick W4 2NR London | British | Banker | 78253140001 | |||||
BARATTA, Joseph Patrick | Administrateur | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | Usa | American | Director | 94259330002 | ||||
BLITZER, David Scott | Administrateur | 5 Priory Walk SW10 9SP London | England | American | Director | 82685720001 | ||||
CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Administrateur | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | Chartered Accountant | 98778780002 | |||||
COLVIN, William | Administrateur | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890001 | ||||
COLVIN, William | Administrateur | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 51697890001 | ||||
EIGHTEEN, Stephen Brian | Administrateur | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | Banker | 76313640003 | ||||
FARNELL, Adrian Colin | Administrateur | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | Chartered Accountant | 43015720002 | ||||
FELTHAM, Emma Rachel | Administrateur désigné | 62 Vane Close Thorpe St Andrew NR7 0US Norwich Norfolk | British | 900024060001 | ||||||
GRANT, Michael John | Administrateur | Edwill Way BR3 6RY Beckenham 73 Kent | England | British | Company Director | 141668610001 | ||||
HUTCHENS, James Justin | Administrateur | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham | United Kingdom | American | Director | 238334580002 | ||||
JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Administrateur | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | Consultant | 108268030003 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Administrateur | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | Company Director | 110640170001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Administrateur | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | Company Director | 110640170001 | ||||
MOY, Neal St John | Administrateur | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | Bank Employee | 98781970001 | |||||
MURPHY, John | Administrateur | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Director | 26177180002 | |||||
NICHOLSON, Daniel Christopher | Administrateur | 181 Seagrave Road SW6 1ST London | England | British | Chartered Surveyor | 77890230001 | ||||
PATEL, Chaitanya Bhupendra | Administrateur | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | United Kingdom | British | Director | 63915280004 | ||||
PIKE, Chad Rustan | Administrateur | 25 Burnsall Street SW3 3SR London | United Kingdom | British | Director | 87606860002 | ||||
POOLEY, Maureen | Administrateur désigné | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | British | 900008180001 | ||||||
RUTTER, Christopher | Administrateur | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Administrateur | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Director | 174231320001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Administrateur | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Chartered Accountant | 77274540003 | ||||
TAYLOR, Paul Vincent | Administrateur | Destiny 49 The Highway SM2 5QS South Sutton Surrey | United Kingdom | British | Principal | 71978710001 | ||||
THOMPSON, Paul Hugh | Administrateur | St. Johns Road TN13 3LR Sevenoaks 15b Kent United Kingdom | England | British | Consultant | 100977220001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhp Limited | 06 avr. 2016 | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 27 avr. 2021 Livré le 27 avr. 2021 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 27 avr. 2021 Livré le 27 avr. 2021 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 27 avr. 2021 Livré le 27 avr. 2021 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 juin 2017 Livré le 10 juil. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 juin 2017 Livré le 06 juil. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 juin 2017 Livré le 05 juil. 2017 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 nov. 2014 Livré le 27 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A security deed | Créé le 15 janv. 2007 Livré le 30 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H property k/a land lying to the west of ouse acres york t/no NYK303684. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite debenture | Créé le 12 déc. 2006 Livré le 21 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h land k/a ouseacres boroughbridge road, york t/n NYK303684 k/a ouseacres nursing home fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 oct. 2005 Livré le 20 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 11 avr. 2005 Livré le 15 avr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0