NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED

NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNHP OPERATIONS (YORK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04611037
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southgate House
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    County Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEGISLATOR 1618 LIMITED06 déc. 200206 déc. 2002

    Quels sont les derniers comptes de NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 02 nov. 2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Situations in which directors have or can have a direct or indirect interest that conflicts with interest of the company authorised, notwithstanding that any such conflict may breach director's duty under S175 of CA2006. 25/08/2021
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2020

    18 pagesAA

    Satisfaction de la charge 046110370006 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 046110370007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 046110370008 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 046110370009, créée le 27 avr. 2021

    57 pagesMR01

    Inscription de la charge 046110370010, créée le 27 avr. 2021

    90 pagesMR01

    Inscription de la charge 046110370011, créée le 27 avr. 2021

    216 pagesMR01

    Nomination de Mr James Walter Tugendhat en tant qu'administrateur le 14 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    19 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Justin Hutchens en tant que directeur le 05 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    19 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Justin Hutchens le 08 janv. 2018

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Administrateur
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritishDirector147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Administrateur
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director218306870001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Secrétaire
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secrétaire
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    BritishCompany Secretary108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    BritishCompany Secretary70194600001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Secrétaire
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    BritishCompany Director110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Secrétaire
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    BritishCompany Director110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Secrétaire
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Secrétaire
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    MalaysianGroup Financial Controller140239060001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire désigné
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    British900008180001
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Administrateur
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    BritishBanker78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Administrateur
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmericanDirector94259330002
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Administrateur
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmericanDirector82685720001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    BritishChartered Accountant98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director51697890001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Administrateur
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritishBanker76313640003
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant43015720002
    FELTHAM, Emma Rachel
    62 Vane Close
    Thorpe St Andrew
    NR7 0US Norwich
    Norfolk
    Administrateur désigné
    62 Vane Close
    Thorpe St Andrew
    NR7 0US Norwich
    Norfolk
    British900024060001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Administrateur
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritishCompany Director141668610001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Administrateur
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomAmericanDirector238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Administrateur
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritishConsultant108268030003
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Administrateur
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritishCompany Director110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Administrateur
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritishCompany Director110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Administrateur
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    BritishBank Employee98781970001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Administrateur
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    BritishDirector26177180002
    NICHOLSON, Daniel Christopher
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    Administrateur
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    EnglandBritishChartered Surveyor77890230001
    PATEL, Chaitanya Bhupendra
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Administrateur
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritishDirector63915280004
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Administrateur
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritishDirector87606860002
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Administrateur désigné
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    British900008180001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishDirector174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Administrateur
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishChartered Accountant77274540003
    TAYLOR, Paul Vincent
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    Administrateur
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    United KingdomBritishPrincipal71978710001
    THOMPSON, Paul Hugh
    St. Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant100977220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Nhp Limited
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    England
    06 avr. 2016
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompany Law
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement2798607
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    NHP OPERATIONS (YORK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 avr. 2021
    Livré le 27 avr. 2021
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transactions
    • 27 avr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 avr. 2021
    Livré le 27 avr. 2021
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transactions
    • 27 avr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 avr. 2021
    Livré le 27 avr. 2021
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transactions
    • 27 avr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 juin 2017
    Livré le 10 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transactions
    • 10 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 juin 2017
    Livré le 06 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 06 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 juin 2017
    Livré le 05 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transactions
    • 05 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 nov. 2014
    Livré le 27 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hcp, Inc. (As Security Agent)
    Transactions
    • 27 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security deed
    Créé le 15 janv. 2007
    Livré le 30 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land lying to the west of ouse acres york t/no NYK303684. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse, London Branch
    Transactions
    • 30 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 12 déc. 2006
    Livré le 21 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h land k/a ouseacres boroughbridge road, york t/n NYK303684 k/a ouseacres nursing home fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 21 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2005
    Livré le 20 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 20 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0