DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04611280 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | Bickerton House C/O Pemberton Capital Llp 25 Bickerton Road N19 5JU London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 29 juin 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Oliver Charles Tonkin en tant que directeur le 28 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 29 juin 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd England à Bickerton House C/O Pemberton Capital Llp 25 Bickerton Road London N19 5JU le 28 sept. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2017 au 29 juin 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Domes of Silence Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 18-19 Princewood Road Corby Northamptonshire NN17 4AP à C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd le 15 août 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan John Simpson en tant que secrétaire le 14 août 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Anthony Cooke en tant que directeur le 25 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Siegfried Meyer en tant que directeur le 25 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2016 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2015 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Alan John Simpson le 20 mai 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2014 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes établis au 30 juin 2013 | 18 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKE, Martin Anthony | Secrétaire | Uggool Moycullen Galway Ireland | Irish | 87347070001 | ||||||
| FOWLER, Sean Martin | Secrétaire | 5 Lanchester Green The Chesters NE22 6JP Bedlington Northumberland | British | 98759900001 | ||||||
| MOLLEKIN, Stuart James | Secrétaire | 47 Amberhill Way Worsley M28 1YJ Manchester | British | 36939710003 | ||||||
| SIMPSON, Alan John | Secrétaire | 18-19 Princewood Road Corby NN17 4AP Northamptonshire | British | 82321910002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| COOKE, Martin Anthony | Administrateur | Uggool Moycullen Galway Ireland | Ireland | Irish | 87347070001 | |||||
| HARDMAN, Andrew George | Administrateur | 9 Sarah West Close NR2 2TE Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 44617960003 | |||||
| MEYER, Michael Siegfried | Administrateur | 53 Chelsea Crescent Chelsea Harbour SW10 0XB London | England | British | 1488770001 | |||||
| MOLLEKIN, Stuart James | Administrateur | 47 Amberhill Way Worsley M28 1YJ Manchester | England | British | 36939710003 | |||||
| TONKIN, Oliver Charles | Administrateur | C/O Pemberton Capital Llp 25 Bickerton Road N19 5JU London Bickerton House England | United Kingdom | British | 132929440001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domes Of Silence Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 207 Regent Street W1B 4ND London C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 29 nov. 2010 Livré le 16 déc. 2010 | En cours | Montant garanti £1,495,000.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 12 mai 2010 Livré le 28 mai 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 mai 2008 Livré le 28 mai 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 mars 2006 Livré le 30 mars 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to brillington limited, tim bohan limited and maria murphy | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 16 janv. 2006 Livré le 17 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage all property, by way of fixed charge the f/h and l/h properties all fixtures and fittings and fixed plant and machinery all goodwill unpaid and/or uncalled capital all intellectual property all stocks shares bonds and securities all loan capital all non-vesting debts. By way of floating charge all other property assets and rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 sept. 2005 Livré le 29 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any f/h or l/h property,all fixtures and fittings,all the plant and machinery,vehicles and computer equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A security agreement | Créé le 25 févr. 2003 Livré le 06 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All estates or interests in any freehold or leasehold property now belonging to it, and all group shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights accruing to the group shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0