DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED

DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDOMES OF SILENCE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04611280
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bickerton House C/O Pemberton Capital Llp
    25 Bickerton Road
    N19 5JU London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DIRECT MESSAGE GROUP LIMITED04 févr. 200304 févr. 2003
    WEAVETOWER LIMITED06 déc. 200206 déc. 2002

    Quels sont les derniers comptes de DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 juin 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Oliver Charles Tonkin en tant que directeur le 28 juin 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 29 juin 2018

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd England à Bickerton House C/O Pemberton Capital Llp 25 Bickerton Road London N19 5JU le 28 sept. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017

    8 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2017 au 29 juin 2017

    1 pagesAA01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Domes of Silence Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02

    Changement d'adresse du siège social de 18-19 Princewood Road Corby Northamptonshire NN17 4AP à C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd le 15 août 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Alan John Simpson en tant que secrétaire le 14 août 2017

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Martin Anthony Cooke en tant que directeur le 25 août 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Siegfried Meyer en tant que directeur le 25 août 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juil. 2016

    État du capital au 08 juil. 2016

    • Capital: GBP 20,022,169
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 mai 2015

    État du capital au 20 mai 2015

    • Capital: GBP 20,022,169
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Alan John Simpson le 20 mai 2015

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 mai 2014

    État du capital au 23 mai 2014

    • Capital: GBP 20,022,169
    SH01

    Comptes établis au 30 juin 2013

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COOKE, Martin Anthony
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Secrétaire
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Irish87347070001
    FOWLER, Sean Martin
    5 Lanchester Green
    The Chesters
    NE22 6JP Bedlington
    Northumberland
    Secrétaire
    5 Lanchester Green
    The Chesters
    NE22 6JP Bedlington
    Northumberland
    British98759900001
    MOLLEKIN, Stuart James
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    Secrétaire
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    British36939710003
    SIMPSON, Alan John
    18-19 Princewood Road
    Corby
    NN17 4AP Northamptonshire
    Secrétaire
    18-19 Princewood Road
    Corby
    NN17 4AP Northamptonshire
    British82321910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COOKE, Martin Anthony
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Administrateur
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    IrelandIrish87347070001
    HARDMAN, Andrew George
    9 Sarah West Close
    NR2 2TE Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    9 Sarah West Close
    NR2 2TE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish44617960003
    MEYER, Michael Siegfried
    53 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    Administrateur
    53 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    EnglandBritish1488770001
    MOLLEKIN, Stuart James
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    Administrateur
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    EnglandBritish36939710003
    TONKIN, Oliver Charles
    C/O Pemberton Capital Llp
    25 Bickerton Road
    N19 5JU London
    Bickerton House
    England
    Administrateur
    C/O Pemberton Capital Llp
    25 Bickerton Road
    N19 5JU London
    Bickerton House
    England
    United KingdomBritish132929440001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    207 Regent Street
    W1B 4ND London
    C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor
    England
    06 avr. 2016
    207 Regent Street
    W1B 4ND London
    C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05458736
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 nov. 2010
    Livré le 16 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    £1,495,000.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Pemcap Acquisitions Limited & Pemcap Investments Limited
    Transactions
    • 16 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 mai 2010
    Livré le 28 mai 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 28 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 22 mai 2008
    Livré le 28 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 30 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to brillington limited, tim bohan limited and maria murphy
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Brillington Limited, Tim Bohan Limited and Maria Murphy
    Transactions
    • 30 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 janv. 2006
    Livré le 17 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all property, by way of fixed charge the f/h and l/h properties all fixtures and fittings and fixed plant and machinery all goodwill unpaid and/or uncalled capital all intellectual property all stocks shares bonds and securities all loan capital all non-vesting debts. By way of floating charge all other property assets and rights.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 17 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any f/h or l/h property,all fixtures and fittings,all the plant and machinery,vehicles and computer equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Brillington Limited,Tim Bohan Limited and Maria Murphy
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A security agreement
    Créé le 25 févr. 2003
    Livré le 06 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All estates or interests in any freehold or leasehold property now belonging to it, and all group shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights accruing to the group shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 06 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0