LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04615065 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 21 Webb Close GU19 5QP Bagshot Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des détails de Peter George Lamb en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 nov. 2018 | 2 pages | PSC04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Peter George Lamb le 13 nov. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Jennifer Ann Lamb le 13 nov. 2018 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Knoll House Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY England à 21 Webb Close Bagshot Surrey GU19 5QP le 13 nov. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2017 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Peter George Lamb le 20 oct. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2016 au 30 mars 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Almac House Church Lane Bisley Surrey GU24 9DR à Knoll House Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY le 06 oct. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 046150650008, créée le 08 janv. 2016 | 50 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 5 | 5 pages | MR05 | ||||||||||
Inscription de la charge 046150650007, créée le 29 août 2014 | 8 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 046150650006, créée le 27 août 2014 | 43 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMB, Jennifer Ann | Secrétaire | Webb Close GU19 5QP Bagshot 21 Surrey United Kingdom | British | 24578630004 | ||||||
| LAMB, Peter George | Administrateur | Webb Close GU19 5QP Bagshot 21 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 40329010007 | |||||
| LAMB, Peter George | Secrétaire | Forge Cottage Ockham Lane GU23 6NP Ockham Surrey | British | 40329010003 | ||||||
| KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED | Secrétaire désigné | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004240001 | |||||||
| KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED | Administrateur désigné | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004230001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Peter George Lamb | 06 avr. 2016 | Webb Close GU19 5QP Bagshot 21 Surrey United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 08 janv. 2016 Livré le 08 janv. 2016 | En cours | ||
Brève description Land adjoining crown house, 120 medstead road, beech, alton GU34 4AF as registered at the land registry under title number SH40270. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 29 août 2014 Livré le 16 sept. 2014 | En cours | ||
Brève description Freehold property on the north side of mdstead road beech alton hants. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 27 août 2014 Livré le 05 sept. 2014 | En cours | ||
Brève description Land on the north side of medstead road (adjoining 59 wellhouse road), beech, alton, hampshire GU34 4AQ registered under part of title number SH36206 at the land registry. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 oct. 2011 Livré le 15 oct. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 oct. 2011 Livré le 15 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a daneshill the reeds road frensham farnham t/no SY351869 first fixed charge all its rights in any policies of insurance,the benefit of all contracts guarantees appointments,warranties and other documents see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 04 juil. 2008 Livré le 08 juil. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H danehill, millbridge, frensham, surrey t/no SY351869 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 05 août 2005 Livré le 10 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 93 seymour road headley down bordon t/no SH17872. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 août 2005 Livré le 10 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0