LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED

LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04615065
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    21 Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Modification des détails de Peter George Lamb en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 nov. 2018

    2 pagesPSC04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter George Lamb le 13 nov. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Jennifer Ann Lamb le 13 nov. 2018

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Knoll House Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY England à 21 Webb Close Bagshot Surrey GU19 5QP le 13 nov. 2018

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2017 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter George Lamb le 20 oct. 2017

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2016 au 30 mars 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Almac House Church Lane Bisley Surrey GU24 9DR à Knoll House Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY le 06 oct. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    7 pagesAA

    Inscription de la charge 046150650008, créée le 08 janv. 2016

    50 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 déc. 2015

    État du capital au 15 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2014

    État du capital au 16 déc. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 5

    5 pagesMR05

    Inscription de la charge 046150650007, créée le 29 août 2014

    8 pagesMR01

    Inscription de la charge 046150650006, créée le 27 août 2014

    43 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2013

    État du capital au 18 déc. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAMB, Jennifer Ann
    Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    21
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    21
    Surrey
    United Kingdom
    British24578630004
    LAMB, Peter George
    Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    21
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    21
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish40329010007
    LAMB, Peter George
    Forge Cottage
    Ockham Lane
    GU23 6NP Ockham
    Surrey
    Secrétaire
    Forge Cottage
    Ockham Lane
    GU23 6NP Ockham
    Surrey
    British40329010003
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Secrétaire désigné
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Administrateur désigné
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peter George Lamb
    Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    21
    Surrey
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Webb Close
    GU19 5QP Bagshot
    21
    Surrey
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    LANDMARK COUNTRY HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 08 janv. 2016
    Livré le 08 janv. 2016
    En cours
    Brève description
    Land adjoining crown house, 120 medstead road, beech, alton GU34 4AF as registered at the land registry under title number SH40270.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Funding Circle Property Finance Limited
    Transactions
    • 08 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 août 2014
    Livré le 16 sept. 2014
    En cours
    Brève description
    Freehold property on the north side of mdstead road beech alton hants.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Classic Home Company (Southern) Limited
    Transactions
    • 16 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 août 2014
    Livré le 05 sept. 2014
    En cours
    Brève description
    Land on the north side of medstead road (adjoining 59 wellhouse road), beech, alton, hampshire GU34 4AQ registered under part of title number SH36206 at the land registry.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Funding Circle Property Finance Limited
    Transactions
    • 05 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 06 oct. 2011
    Livré le 15 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 15 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 sept. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 06 oct. 2011
    Livré le 15 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a daneshill the reeds road frensham farnham t/no SY351869 first fixed charge all its rights in any policies of insurance,the benefit of all contracts guarantees appointments,warranties and other documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 15 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 04 juil. 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H danehill, millbridge, frensham, surrey t/no SY351869 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 10 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    93 seymour road headley down bordon t/no SH17872. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 10 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0