GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED

GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04620798
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED ?

    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Changement d'adresse du siège social de 7 More London Riverside London SE1 2RT à Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds North Yorkshire LS1 4DL le 25 nov. 2017

    2 pagesAD01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state certificate of release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2016

    17 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:court order replacement/removal of liquidator
    10 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2015

    11 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2014

    10 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 05 nov. 2013

    23 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 juin 2013

    23 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Glenn Timms en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    32 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * Royal Mead Railway Place Bath BA1 1SR England* le 21 janv. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Richard Lyons en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Deborah Catherine Ann Bowring en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Bryan Park en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Glenn Gordon Timms en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Arthur Tompkins en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 8 Riverside Court Lower Bristol Road Bath North East Somerset BA2 3DZ* le 16 avr. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    22 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    METTERS, Richard
    15 Dartmouth Walk
    Keynsham
    BS31 2NZ Bristol
    Avon
    Secrétaire
    15 Dartmouth Walk
    Keynsham
    BS31 2NZ Bristol
    Avon
    BritishEngineering Manager121082230001
    BOWRING, Deborah Catherine Ann
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Floor 8 Central Square
    North Yorkshire
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Floor 8 Central Square
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector173998140001
    PARK, Bryan
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Floor 8 Central Square
    North Yorkshire
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Floor 8 Central Square
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector113694470002
    BOWEN, Carolyn Irene
    Crossland
    1 Sion Road Lansdown
    BA1 5SQ Bath
    Avon
    Secrétaire
    Crossland
    1 Sion Road Lansdown
    BA1 5SQ Bath
    Avon
    British107842890001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DESCHUYTER, Johan Eugene
    Warandestraat 22a
    Torhout
    8820
    Belgium
    Administrateur
    Warandestraat 22a
    Torhout
    8820
    Belgium
    BelgiumBelgianCompany Director113903670001
    LYONS, Richard Henry
    12 Berkley Road
    BA11 2ED Frome
    Somerset
    Administrateur
    12 Berkley Road
    BA11 2ED Frome
    Somerset
    EnglandBritishChartered Engineer86987260001
    TIMMS, Glenn Gordon
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Administrateur
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritishDirector172175310001
    TOMPKINS, Arthur Charles
    Railway Place
    BA1 1SR Bath
    Royal Mead
    England
    Administrateur
    Railway Place
    BA1 1SR Bath
    Royal Mead
    England
    EnglandBritishDirector209828260001
    WRIGHT, Andrew Charles Stuart, Dr
    Roetelistr. 14
    St. Gallen
    9000
    Switzerland
    Administrateur
    Roetelistr. 14
    St. Gallen
    9000
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director103335790001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture and guarantee
    Créé le 03 mars 2011
    Livré le 12 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the target and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 12 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite debenture and guarantee
    Créé le 03 mars 2011
    Livré le 12 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the principal and each grantor of security to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv (The Lender)
    Transactions
    • 12 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite debenture and guarantee
    Créé le 03 mars 2011
    Livré le 12 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the principal and each grantor of security to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Belgie Nv (The Lender)
    Transactions
    • 12 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite debenture and guarantee
    Créé le 03 mars 2011
    Livré le 12 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the principal and each grantor of security to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa/Nv (The Lender)
    Transactions
    • 12 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 avr. 2003
    Livré le 26 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Six thousand six hundred and twenty five pounds (£6,625.00).
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Matrix Senior Executive Pension Scheme
    Transactions
    • 26 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MARINE SURVEYS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 déc. 2012Administration started
    05 nov. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    31 Great George Street
    BS1 5QD Bristol
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    31 Great George Street
    BS1 5QD Bristol
    2
    DateType
    05 nov. 2013Commencement of winding up
    03 févr. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    31 Great George Street
    BS1 5QD Bristol
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    31 Great George Street
    BS1 5QD Bristol

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0