COATS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COATS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04620973 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COATS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4th Floor 14 Aldermanbury Square EC2V 7HS London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COATS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COATS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 14 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 28 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 14 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COATS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2025 | 56 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Hannah Kate Nichols le 24 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 nov. 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Coats Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 oct. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS13 8FD England à 4th Floor 14 Aldermanbury Square London EC2V 7HS le 15 sept. 2025 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 09 sept. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Farnaz Ranjbar en tant que directeur le 31 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Farnaz Ranjbar le 24 juin 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Ms Hannah Kate Nichols en tant qu'administrateur le 21 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jacqueline Wynn Callaway en tant que directeur le 21 mai 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 55 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rajiv Sharma en tant que directeur le 30 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 57 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Jacqueline Wynn Callaway le 15 mars 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Coats Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 oct. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rajiv Sharma le 10 oct. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 52 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Charles Mann en tant qu'administrateur le 31 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 déc. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 30 nov. 2022
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Modification des détails de Coats Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 oct. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE England à The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS13 8FD le 03 oct. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COATS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN, Stuart John | Secrétaire | 14 Aldermanbury Square EC2V 7HS London 4th Floor England | 191230510001 | |||||||
| MANN, Robert Charles | Administrateur | 14 Aldermanbury Square EC2V 7HS London 4th Floor England | England | British | 303844260001 | |||||
| MORGAN, Stuart John | Administrateur | 14 Aldermanbury Square EC2V 7HS London 4th Floor England | England | British | 184237140001 | |||||
| NICHOLS, Hannah Kate | Administrateur | 14 Aldermanbury Square EC2V 7HS London 4th Floor England | United Kingdom | British | 335039580002 | |||||
| ALDRIDGE, Gemma Jane Constance | Secrétaire | 54 Crown Street HA2 0HR Harrow On The Hill Middlesex | British | 144966000001 | ||||||
| BEVAN, Roger | Secrétaire | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | British | 99478770001 | ||||||
| GIBSON, Carolyn Ann | Secrétaire | 10 Hanger Hill KT13 9XR Weybridge Surrey | British | 59736770001 | ||||||
| RUSSELL, James Richard | Secrétaire | The Old Stables Empingham Road PE9 3RP Ketton Rutland | British | 904390002 | ||||||
| SAUNT, Timothy Patrick | Secrétaire | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | 168164870001 | |||||||
| SAUNT, Timothy Patrick | Secrétaire | Beechwood House Ashley Kings Somborne SO20 6RH Stockbridge Hampshire | British | 58873990003 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| ALLEN, Michael Nicholas | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | New Zealand | New Zealander | 154487670001 | |||||
| ANDERSON, Moreen Ruth | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 185034410002 | |||||
| BODDIE, Simon | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | United Kingdom | British | 289650160001 | |||||
| BUTCHER, Alexander Mark | Administrateur | 18 River House The Terrace Barnes SW13 0NR London | Britain | British | 36800400004 | |||||
| CALLAWAY, Jacqueline Wynn | Administrateur | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | New Zealander | 277130130002 | |||||
| CAMPBELL, Robert James | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | New Zealand | New Zealander | 281138640001 | |||||
| CLASPER, Michael | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 181056620001 | |||||
| FORMAN, Paul Anthony | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 148204660001 | |||||
| FORMAN, Paul Anthony | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 148283170001 | |||||
| GIBBS, Anthony Ian | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | New Zealand | New Zealander British | 98145010001 | |||||
| GLEAVE, Clinton John Raymond | Administrateur | 14 Kenneth Crescent Willesden Green NW2 4PT London | England | British | 48349150003 | |||||
| GOSNELL, David Peter | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | England | British | 71048770002 | |||||
| HEALE, Simon John Newton | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | England | British | 104569010001 | |||||
| HOWES, Richard David | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | England | British | 265695690001 | |||||
| LAVIGNE, Donald Stanton | Administrateur | 16 Trevor Place SW7 1LB London | American | 87941570002 | ||||||
| LOH, Isabella Wai Kiew | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | Singapore | Singaporean | 160984070001 | |||||
| MCKEE, Monica Therese | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | England | British | 72949670001 | |||||
| NIXON, Blake Andrew | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | England | British | 5872150007 | |||||
| RANJBAR, Farnaz | Administrateur | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | German | 298571990002 | |||||
| ROSLING, Richard Alan | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | Hong Kong | British | 195444690001 | |||||
| RUSSELL, James Richard | Administrateur | The Old Stables Empingham Road PE9 3RP Ketton Rutland | England | British | 904390002 | |||||
| SHARMA, Rajiv | Administrateur | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | Singapore | Singaporean | 217947040002 | |||||
| SMITHYMAN, Michael James | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 93678690003 | |||||
| SZLEZAK, Waldemar | Administrateur | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | Usa | American | 177008400001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COATS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coats Group Plc | 06 avr. 2016 | 14 Aldermanbury Square EC2V 7HS London 4th Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0