OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED

OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04621456
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2018

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2017

    7 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de The Place Ducie Street Manchester M1 2TP à 15 Canada Square London E14 5GL le 20 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2016

    LRESSP

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    19 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2016

    État du capital au 04 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    19 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2016

    État du capital au 04 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2013

    19 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2016

    État du capital au 04 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ

    2 pagesAD02

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    47 pages1.4

    Cessation de la nomination de Brett Alan Lashley en tant que directeur le 04 juin 2015

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard James Spencer en tant qu'administrateur le 04 juin 2015

    3 pagesAP01

    Nomination de Brett Alan Lashley en tant qu'administrateur le 25 févr. 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Allan Mellor en tant que secrétaire le 25 févr. 2015

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Gavin Robert Duncan en tant que directeur le 25 févr. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stuart Barrie Wall en tant que directeur le 25 févr. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Craig Allan Mellor en tant que directeur le 25 févr. 2015

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à The Place Ducie Street Manchester M1 2TP le 06 mars 2015

    2 pagesAD01

    Avis de fin de l'administration

    72 pages2.32B

    Qui sont les dirigeants de OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPENCER, Richard James
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Administrateur
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Administrateur
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Administrateur
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Administrateur
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Group debenture
    Créé le 04 avr. 2012
    Livré le 19 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transactions
    • 19 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 218 nov. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 219 déc. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 2
    Assignment by way of security
    Créé le 28 avr. 2006
    Livré le 09 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to those agreements being a building contract and a performance bond and any present or future collateral warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 09 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 27 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the f/h property being land and buildings at 4 milton street sheffield t/no SYK457967 together with the l/h property t/no SYK435519 by way of assignment the gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter in respect of or arising out of any lease or any agreement for lease or otherwise, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements, by way of fixed charge all funds standing to the credit of the company, by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or for time to time.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 27 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2003
    Livré le 19 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 19 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 08 mai 2003
    Livré le 19 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The freehold property known as land and buildings at wellington street sheffield t/n SYK381544 together with the gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter in respect of or arising out of any lease of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 19 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)

    OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mars 2013Administration started
    20 févr. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    receiver manager
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    receiver manager
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    3
    DateType
    12 déc. 2014Date of meeting to approve CVA
    22 oct. 2015Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    DateType
    30 sept. 2016Commencement of winding up
    22 août 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0