OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04621456 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 7 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2018 | 7 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2017 | 7 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Place Ducie Street Manchester M1 2TP à 15 Canada Square London E14 5GL le 20 oct. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 19 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 19 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2013 | 19 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Avis d'achèvement de l'accord volontaire | 47 pages | 1.4 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brett Alan Lashley en tant que directeur le 04 juin 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard James Spencer en tant qu'administrateur le 04 juin 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Brett Alan Lashley en tant qu'administrateur le 25 févr. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Craig Allan Mellor en tant que secrétaire le 25 févr. 2015 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Robert Duncan en tant que directeur le 25 févr. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Barrie Wall en tant que directeur le 25 févr. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Craig Allan Mellor en tant que directeur le 25 févr. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à The Place Ducie Street Manchester M1 2TP le 06 mars 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Avis de fin de l'administration | 72 pages | 2.32B | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER, Richard James | Administrateur | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | United Kingdom | British | 190526870001 | |||||
| MELLOR, Craig Allan | Secrétaire | 21 Queenston Road Didsbury M20 2NX Manchester | British | 60906780002 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| DUNCAN, Gavin Robert | Administrateur | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | 151512820001 | |||||
| LASHLEY, Brett Alan | Administrateur | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | United States Of America | 196201790001 | |||||
| MARTIN, Graham Hunter | Administrateur | Rosegarth 51 Adlington Road SK9 2BJ Wilmslow Cheshire | British | 87259480001 | ||||||
| MELLOR, Craig Allan | Administrateur | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | 60906780002 | |||||
| WALL, Stuart Barrie | Administrateur | Old Acres Well Bank Lane Over Peover WA16 8UN Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 95010340001 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Créé le 04 avr. 2012 Livré le 19 avr. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Assignment by way of security | Créé le 28 avr. 2006 Livré le 09 mai 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in and to those agreements being a building contract and a performance bond and any present or future collateral warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 27 mai 2003 Livré le 27 mai 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage the f/h property being land and buildings at 4 milton street sheffield t/no SYK457967 together with the l/h property t/no SYK435519 by way of assignment the gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter in respect of or arising out of any lease or any agreement for lease or otherwise, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements, by way of fixed charge all funds standing to the credit of the company, by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or for time to time. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 mai 2003 Livré le 19 mai 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 08 mai 2003 Livré le 19 mai 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The freehold property known as land and buildings at wellington street sheffield t/n SYK381544 together with the gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter in respect of or arising out of any lease of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In administration |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Receiver/Manager appointed |
| |||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 4 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0