SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED

SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSERVEST BUILDING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04626399
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    • Activités combinées de soutien aux installations (81100) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Servest House Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Suffolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MAXWELL STEWART MAINTENANCE LIMITED31 déc. 200231 déc. 2002

    Quels sont les derniers comptes de SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 09 août 2021

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Graham Shane Peel en tant que directeur le 05 juil. 2021

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 046263990009 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2018

    15 pagesAA

    legacy

    63 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 046263990008 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Claire-Jayne Green en tant que directeur le 28 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Graham Shane Peel en tant qu'administrateur le 28 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Thomas Edward Evans en tant qu'administrateur le 28 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Phillip Morris en tant que directeur le 03 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthieu De Baynast De Septfontaines en tant que directeur le 05 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Franck Aimé en tant que directeur le 05 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RYAN, Laura Clare
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    Secrétaire
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    246601840001
    EVANS, Thomas Edward
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    EnglandBritish250761870001
    DICKSON, Daniel
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    Secrétaire
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    185251570001
    GEORGE, Belinda Mary
    Albert Embankment
    SE1 7TJ London
    Prince Consort House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Albert Embankment
    SE1 7TJ London
    Prince Consort House
    United Kingdom
    British162982460001
    STOLLIDAY, John David
    41 Hillside Road
    AL5 4BS Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    41 Hillside Road
    AL5 4BS Harpenden
    Hertfordshire
    English26566640001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Secrétaire désigné
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027310001
    AIMÉ, Franck
    Quai Jules Guesde
    94400, Vitry Sur Seine
    111 - 113
    France
    Administrateur
    Quai Jules Guesde
    94400, Vitry Sur Seine
    111 - 113
    France
    FranceFrench246161130001
    CLARKE, Declan James
    Heath Farm Business Centre
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    United KingdomIrish187565910001
    COWLING, Lennord John
    7 Leybourne Road
    UB10 9HB Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    7 Leybourne Road
    UB10 9HB Hillingdon
    Middlesex
    United KingdomBritish95447880001
    DE BAYNAST DE SEPTFONTAINES, Matthieu
    110, Rue De L'Ourcq
    75019, Paris
    La Financiére Atalian
    France
    Administrateur
    110, Rue De L'Ourcq
    75019, Paris
    La Financiére Atalian
    France
    FranceFrench245124870001
    DICKSON, Daniel Grant
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    United KingdomBritish204646470001
    GREEN, Claire-Jayne
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    United KingdomBritish185836190002
    LEGGE, Robert
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    United KingdomBritish71242880002
    MIDDLETON, Paul Christopher
    Heath Farm Business Centre
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    United KingdomBritish99603920003
    MORGAN, Paul Richard
    Blenheim 10 Thirsk Gardens
    Bletchley
    MK3 5HY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Blenheim 10 Thirsk Gardens
    Bletchley
    MK3 5HY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish52314320001
    MORRIS, Phillip James
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    EnglandBritish154417440001
    PEEL, Graham Shane
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    EnglandSouth African251204880001
    PROCTOR, Michael Edward
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    Administrateur
    Heath Farm Business Centre, Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St Edmunds
    Servest House
    Suffolk
    England
    United KingdomBritish154427080001
    STOLLIDAY, John David
    41 Hillside Road
    AL5 4BS Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    41 Hillside Road
    AL5 4BS Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandEnglish26566640001
    VERMERSCH, Stéphane
    110, Rue De L'Ourcq
    75019, Paris
    La Financière Atalian
    France
    Administrateur
    110, Rue De L'Ourcq
    75019, Paris
    La Financière Atalian
    France
    FranceFrench246339950001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Administrateur désigné
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027300001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Servest Group Limited
    Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    England
    06 avr. 2016
    Tut Hill
    Fornham All Saints
    IP28 6LG Bury St. Edmunds
    Servest House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06355228
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SERVEST BUILDING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2017
    Livré le 15 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 juil. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2017
    Livré le 12 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Pursuant to the charge the company charged by way of first fixed charge all of its rights, title and interest in its intellectual property. For further detail, see clause 3.1(b)(ii) of the charge.. Pursuant to the charge the company charged by way of first legal mortgage all freehold and leasehold property (including the property specified in schedule 2 (properties) of the charge). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transactions
    • 12 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 22 févr. 2016
    Livré le 22 févr. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 nov. 2014
    Livré le 18 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 nov. 2014
    Livré le 14 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    As more particularly described in clause 4 of the debenture, fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of servest building services limited.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 mai 2014
    Livré le 15 mai 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 15 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 juil. 2013
    Livré le 16 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    An accession deed to a debenture dated 21 december 2012 (as amended, novated, supplemented, extended or restated, from time to time) creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of maxwell stewart maintenance limited, as more particularly described in clause 6 of the accession deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 16 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 juil. 2013
    Livré le 15 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    As more particularly described in clause 2 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of maxwell stewart maintenance limited.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 oct. 2003
    Livré le 11 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0