KEMP ASSOCIATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKEMP ASSOCIATES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04639924
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    • Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. (93290) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Tehidy Road
    TR14 8TD Camborne
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ETLCD LIMITED15 sept. 202215 sept. 2022
    TRURO CARAVAN AND CAMPING PARK LIMITED03 mai 201103 mai 2011
    ELM TREE LEISURE LIMITED03 juin 200303 juin 2003
    ELM TREE AVIATION LIMITED17 janv. 200317 janv. 2003

    Quels sont les derniers comptes de KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2015
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2015
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 janv. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation31 janv. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat de changement de nom

    Company name changed etlcd LIMITED\certificate issued on 24/05/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name24 mai 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Peter Robert Masters en tant que directeur le 24 mai 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kim Elizabeth Masters en tant que secrétaire le 24 mai 2023

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Micheal John Kemp en tant qu'administrateur le 24 mai 2023

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 97 Fore Street Saltash Cornwall PL12 6AF United Kingdom à 10 Tehidy Road Camborne TR14 8TD le 24 mai 2023

    1 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed truro caravan and camping park LIMITED\certificate issued on 15/09/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name15 sept. 2022

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Robert Masters le 13 sept. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Kim Elizabeth Masters le 13 sept. 2022

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bishop Fleming 16 Queen Square Bristol BS1 4NT à 97 Fore Street Saltash Cornwall PL12 6AF le 13 sept. 2022

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 févr. 2015

    État du capital au 05 févr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 janv. 2014

    État du capital au 22 janv. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    3 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 30 nov. 2011 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de KEMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KEMP, Micheal John
    Tehidy Road
    TR14 8TD Camborne
    10
    England
    Administrateur
    Tehidy Road
    TR14 8TD Camborne
    10
    England
    EnglandBritishProduction Line Worker304213990001
    MASTERS, Kim Elizabeth
    Fore Street
    PL12 6AF Saltash
    99
    Cornwall
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fore Street
    PL12 6AF Saltash
    99
    Cornwall
    United Kingdom
    British150282290001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MASTERS, Peter Robert
    Fore Street
    PL12 6AF Saltash
    99
    Cornwall
    United Kingdom
    Administrateur
    Fore Street
    PL12 6AF Saltash
    99
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomEnglishDirector80783070007
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    KEMP ASSOCIATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 05 déc. 2011
    Livré le 08 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 29 sept. 2009
    Livré le 14 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 28 mars 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    32 trelawney avenue treskerby redruth cornwall t/no CL7162 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 mars 2008
    Livré le 06 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 23 scorrier street st day redruth cornwall t/no CL243274 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 sept. 2007
    Livré le 13 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a albany farm green botton chacewater t/no CL136635. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 10 juil. 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 4 buckingham terrace st day redruth t/no CL160981. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 10 juil. 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 1 ocean court sandy road eastcliff porthowan t/no CL128989. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 juil. 2007
    Livré le 12 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 54 hallane road st austell cornwall t/no CL25698. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 15 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    31 station road pool redruth cornwall t/no CL123148. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 10 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a lisket holiday park greenbottom truro cornwall. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0