IMCO RECONOMY 2 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | IMCO RECONOMY 2 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04656866 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?
Adresse du siège social | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 22 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 15 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant que secrétaire le 15 juin 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 22 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John Price en tant que directeur le 06 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Price en tant que secrétaire le 06 juin 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2016 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Price en tant que secrétaire le 07 oct. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Francis Dear en tant que directeur le 07 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Anthony Cox en tant qu'administrateur le 07 oct. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher John Price en tant qu'administrateur le 07 oct. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Nelson House Bergen Way King's Lynn Norfolk PE30 2JG à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 20 oct. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark William Garwood en tant que directeur le 07 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Christopher Collins en tant que directeur le 07 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULLIVAN, John Terence | Secrétaire | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 209205780001 | |||||||
COX, Paul Anthony | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Company Director | 153797870001 | ||||
SULLIVAN, John Terence | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Chartered Accountant | 180046340001 | ||||
BOLGER, Eamon Joseph | Secrétaire | 149 Ard Na Mara Malahide IRISH Dublin Ireland | Irish | Company Director | 114519590001 | |||||
COLLINS, Robert Christopher | Secrétaire | Bergen Way PE30 2JG King's Lynn Nelson House Norfolk | 161321120001 | |||||||
COOPER, Mandy Jane | Secrétaire | 3 Laurel Cottages Terrington St. Clement PE34 4JB Kings Lynn Norfolk | British | Company Secretary | 80956030001 | |||||
DAVIS, Andrew Peter | Secrétaire | 22 Oxfield Drive Gorefield PE13 5AH Wisbech Cambridgeshire | British | 112034120002 | ||||||
PRICE, Christopher | Secrétaire | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 202019090001 | |||||||
STRUNKS, Christina Susan | Secrétaire | Low Road North Tuddenham NR20 3DQ Dereham Rowtree Cottage Norfolk | British | 138172740001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
COLLINS, Robert Christopher | Administrateur | Bergen Way PE30 2JG King's Lynn Nelson House Norfolk | United Kingdom | British | Accountant | 15842110002 | ||||
DEAR, Christopher Francis | Administrateur | Winterberry House 45 St. Paul's Road North, Walton Highway PE14 7DN Wisbech Cambridgeshire | United Kingdom | British | Company Director | 127472970001 | ||||
DEAR, Christopher Francis | Administrateur | 32 Spencer Close West Walton PE14 7EN Wisbech Cambridgeshire | British | Company Director | 87551800001 | |||||
GARWOOD, Mark William | Administrateur | Baker Link Eynesbury PE19 2HY St Neots 1 Cambridgeshire | United Kingdom | British | Development Manager | 110920360002 | ||||
HUTTON, Matthew James | Administrateur | 21 Penfold Cottages Holmer Green HP15 6XR High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Operations Director | 122933270001 | ||||
PRICE, Christopher John | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Company Director | 158399250001 | ||||
TOPHAM, Michael | Administrateur | 4 Croft Close Chalfont St Peter SL9 9FD Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | Financial Director | 123785340001 | ||||
WAKELIN, Ian Raymond | Administrateur | Fox Covert Farm Marsh Gibbon OX6 0AQ Bicester Oxfordshire | England | British | Managing Director | 80196120001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reconomy (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
IMCO RECONOMY 2 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 11 juin 2010 Livré le 15 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 juil. 2009 Livré le 09 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 juin 2008 Livré le 09 juil. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 14 févr. 2007 Livré le 16 févr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 07 avr. 2003 Livré le 10 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0