IMCO RECONOMY 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIMCO RECONOMY 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04656866
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JUST HIRE UK LIMITED20 mai 200920 mai 2009
    CHRIS DEAR MANAGEMENT LIMITED13 mai 200913 mai 2009
    GREENSTAR (NWS) LIMITED04 sept. 200804 sept. 2008
    NETWORK WASTE SOLUTIONS LIMITED30 nov. 200430 nov. 2004
    SITE SERVICES (GB) LIMITED05 févr. 200305 févr. 2003

    Quels sont les derniers comptes de IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 15 juin 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant que secrétaire le 15 juin 2016

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher John Price en tant que directeur le 06 juin 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Price en tant que secrétaire le 06 juin 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2016

    État du capital au 23 févr. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2016 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Mr Christopher Price en tant que secrétaire le 07 oct. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher Francis Dear en tant que directeur le 07 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Anthony Cox en tant qu'administrateur le 07 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher John Price en tant qu'administrateur le 07 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Nelson House Bergen Way King's Lynn Norfolk PE30 2JG à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 20 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Mark William Garwood en tant que directeur le 07 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Christopher Collins en tant que directeur le 07 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secrétaire
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    209205780001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishCompany Director153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant180046340001
    BOLGER, Eamon Joseph
    149 Ard Na Mara
    Malahide
    IRISH Dublin
    Ireland
    Secrétaire
    149 Ard Na Mara
    Malahide
    IRISH Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director114519590001
    COLLINS, Robert Christopher
    Bergen Way
    PE30 2JG King's Lynn
    Nelson House
    Norfolk
    Secrétaire
    Bergen Way
    PE30 2JG King's Lynn
    Nelson House
    Norfolk
    161321120001
    COOPER, Mandy Jane
    3 Laurel Cottages
    Terrington St. Clement
    PE34 4JB Kings Lynn
    Norfolk
    Secrétaire
    3 Laurel Cottages
    Terrington St. Clement
    PE34 4JB Kings Lynn
    Norfolk
    BritishCompany Secretary80956030001
    DAVIS, Andrew Peter
    22 Oxfield Drive
    Gorefield
    PE13 5AH Wisbech
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    22 Oxfield Drive
    Gorefield
    PE13 5AH Wisbech
    Cambridgeshire
    British112034120002
    PRICE, Christopher
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secrétaire
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    202019090001
    STRUNKS, Christina Susan
    Low Road
    North Tuddenham
    NR20 3DQ Dereham
    Rowtree Cottage
    Norfolk
    Secrétaire
    Low Road
    North Tuddenham
    NR20 3DQ Dereham
    Rowtree Cottage
    Norfolk
    British138172740001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COLLINS, Robert Christopher
    Bergen Way
    PE30 2JG King's Lynn
    Nelson House
    Norfolk
    Administrateur
    Bergen Way
    PE30 2JG King's Lynn
    Nelson House
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant15842110002
    DEAR, Christopher Francis
    Winterberry House
    45 St. Paul's Road North, Walton Highway
    PE14 7DN Wisbech
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Winterberry House
    45 St. Paul's Road North, Walton Highway
    PE14 7DN Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director127472970001
    DEAR, Christopher Francis
    32 Spencer Close
    West Walton
    PE14 7EN Wisbech
    Cambridgeshire
    Administrateur
    32 Spencer Close
    West Walton
    PE14 7EN Wisbech
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director87551800001
    GARWOOD, Mark William
    Baker Link
    Eynesbury
    PE19 2HY St Neots
    1
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Baker Link
    Eynesbury
    PE19 2HY St Neots
    1
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishDevelopment Manager110920360002
    HUTTON, Matthew James
    21 Penfold Cottages
    Holmer Green
    HP15 6XR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 Penfold Cottages
    Holmer Green
    HP15 6XR High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishOperations Director122933270001
    PRICE, Christopher John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishCompany Director158399250001
    TOPHAM, Michael
    4 Croft Close
    Chalfont St Peter
    SL9 9FD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    4 Croft Close
    Chalfont St Peter
    SL9 9FD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinancial Director123785340001
    WAKELIN, Ian Raymond
    Fox Covert Farm
    Marsh Gibbon
    OX6 0AQ Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fox Covert Farm
    Marsh Gibbon
    OX6 0AQ Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director80196120001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMCO RECONOMY 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Reconomy (Uk) Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    06 avr. 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrement02951661
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    IMCO RECONOMY 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 11 juin 2010
    Livré le 15 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 15 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 2009
    Livré le 09 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 juin 2008
    Livré le 09 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2007
    Livré le 16 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 16 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 07 avr. 2003
    Livré le 10 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited T/a Alex Lawrie Factors
    Transactions
    • 10 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0