HAZELWOOD ROCK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAZELWOOD ROCK LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04680810
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greyhound Cottages
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2011
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 févr. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation13 mars 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 janv. 2014

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 19 juin 2014

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 janv. 2014

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 juil. 2013

    2 pages3.6

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Uhy Hacker Young St James Building 79 Oxford Street Manchester M1 6HT* le 05 févr. 2013

    1 pagesAD01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 janv. 2013

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 juil. 2012

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 janv. 2012

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 05 juil. 2011

    2 pages3.6

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mars 2011

    État du capital au 08 mars 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010

    4 pagesAA

    legacy

    3 pagesLQ01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gerard O'connor le 27 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Qui sont les dirigeants de HAZELWOOD ROCK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    O'CONNOR, Gerard
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Greyhound Cottages
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Greyhound Cottages
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomIrishProperty Developer81856550002
    GIBBON, Wendy Anne
    19 Lyndhurst Drive
    RM11 1JL Hornchurch
    Essex
    Secrétaire
    19 Lyndhurst Drive
    RM11 1JL Hornchurch
    Essex
    British79532240001
    O'CONNOR, Gerard
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    Secrétaire
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    IrishProperty Developer81856550002
    O'CONNOR, Valerie Ann
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    Secrétaire
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    British118893160001
    HUNDRED HOUSE SECRETARIES LIMITED
    Bank Chambers 1-3 Woodford Avenue
    Gants Hill
    IG2 6UF Ilford
    Essex
    Secrétaire
    Bank Chambers 1-3 Woodford Avenue
    Gants Hill
    IG2 6UF Ilford
    Essex
    83717180001
    OCONNOR, Bridget Philomena
    47 Broome Road
    CM11 1ES Billericay
    Essex
    Administrateur
    47 Broome Road
    CM11 1ES Billericay
    Essex
    BritishAdministrator88272130001
    KINGSLEY BUSINESS SERVICES LIMITED
    Bank Chambers 1-3 Woodford Avenue
    IG2 6UF Ilford
    Essex
    Administrateur désigné
    Bank Chambers 1-3 Woodford Avenue
    IG2 6UF Ilford
    Essex
    900009500001

    HAZELWOOD ROCK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 18 août 2005
    Livré le 01 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 112 juil. 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 101 juil. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 18 août 2005
    Livré le 01 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Charge of a cash deposit
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 17 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company assigns all sums in whatever currency together with all interest and other amounts accruing on them for the time being and from time to time standing to the credit of the account number 06098105 sort code 12-08-95 together with all the companys present and future rights titles and benefit.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 17 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the f/h property k/a land at manor road grays essex with the exception of a strip of land 0.5M in width along the westerly boundary being land in t/n EX331697. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 17 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HAZELWOOD ROCK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anne Clare O'Keefe
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    receiver manager
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Simon Wilson
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    receiver manager
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Kevin James Coates
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    receiver manager
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0