FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED

FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04689986
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ACRAMAN (322) LIMITED07 mars 200307 mars 2003

    Quels sont les derniers comptes de FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mars 2015

    État du capital au 11 mars 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 04 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 03/07/2014
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Richard Downing le 04 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Phillip David Rowland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Stoddard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2008

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    British72002400004
    DOWNING, Simon Richard
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    Administrateur
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    EnglandBritish95005230002
    ROWLAND, Phillip David
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    Administrateur
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    United KingdomBritish147804610001
    BARRETT, Alice Julia
    7 Mead Close
    Stoke St Michael
    BA3 5JB Bath
    Avon
    Secrétaire
    7 Mead Close
    Stoke St Michael
    BA3 5JB Bath
    Avon
    British25502880001
    CHEETHAM, Christopher Andrew
    Lime Cottage
    Prestleigh Road, Evercreech
    BA4 6JY Shepton Mallet
    Somerset
    Secrétaire
    Lime Cottage
    Prestleigh Road, Evercreech
    BA4 6JY Shepton Mallet
    Somerset
    British78076620001
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Secrétaire
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    BARRETT, Alice Julia
    7 Mead Close
    Stoke St Michael
    BA3 5JB Bath
    Avon
    Administrateur
    7 Mead Close
    Stoke St Michael
    BA3 5JB Bath
    Avon
    British25502880001
    CHEETHAM, Christopher Andrew
    Lime Cottage
    Prestleigh Road, Evercreech
    BA4 6JY Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    Lime Cottage
    Prestleigh Road, Evercreech
    BA4 6JY Shepton Mallet
    Somerset
    British78076620001
    DAVIES, Patricia Susan
    28 Croft Road
    BA1 6JJ Bath
    Administrateur
    28 Croft Road
    BA1 6JJ Bath
    British53839630001
    FORRESTER, Duncan Edward
    Eldmere House
    Stoke Hill, Stoke St. Michael
    BA3 5JJ Bath
    Administrateur
    Eldmere House
    Stoke Hill, Stoke St. Michael
    BA3 5JJ Bath
    British91295850001
    HUGHES, Anthony William
    15 Shaftesbury Avenue
    BA1 3DT Bath
    Avon
    Administrateur
    15 Shaftesbury Avenue
    BA1 3DT Bath
    Avon
    British99953260001
    LUM, Kelvin
    Four Elms
    Berkley Road
    BA11 2EH Frome
    Somerset
    Administrateur
    Four Elms
    Berkley Road
    BA11 2EH Frome
    Somerset
    British39055720003
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish72002400004
    TLT DIRECTORS LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Administrateur
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278540002

    FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 sept. 2005
    Livré le 12 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north side of poplar way catcliffe t/n SYK384193. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland the Security Trustee) Acting as Security Trustee for Itself and Each of the Finance Parties
    Transactions
    • 12 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed
    Créé le 11 juil. 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The following assets,both present and future f/h and l/h property together with all buildings and fixtures,first euitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Othe Secured Parties
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Christopher Paul Dixon
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Karen Elizabeth Dixon Life Interest Trust
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 09 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FLARE SOFTWARE SYSTEMS (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juin 2015Commencement of winding up
    08 avr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0