TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED

TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04715302
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED ?

    • Installations de fitness (93130) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROPHERAPY & REHABILITATIONCENTRES LIMITED28 mars 200328 mars 2003

    Quels sont les derniers comptes de TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Andrerw Philip Mellor en tant qu'administrateur le 13 mai 2013

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mai 2013

    État du capital au 09 mai 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    2 pagesAA

    Nomination de Mr Richard Fraser Millman en tant qu'administrateur le 26 févr. 2013

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Robert Fortune en tant que directeur le 06 déc. 2012

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graham Hallworth en tant que directeur le 06 déc. 2012

    2 pagesTM01

    Nomination de Warwick John Ley en tant qu'administrateur le 06 déc. 2012

    3 pagesAP01

    Nomination de Brian Joseph Davidson en tant qu'administrateur le 06 déc. 2012

    3 pagesAP01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2012 au 31 déc. 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    2 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Robert Fortune en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Pearson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Statuts

    7 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de John Peers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr James Lee Pearson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham Hallworth en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Jackson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TOTAL HEALTH EXERCISE HYDROTHERAPY & REHABILITATION CENTRES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIDSON, Brian Joseph
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    EnglandBritishNone175162820001
    LEY, Warwick John
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    EnglandAustralian,BritishNone132365050002
    MELLOR, Andrew Philip
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    EnglandBritishNone178703700001
    MILLMAN, Richard Fraser
    Rehabilitation Centre Ltd
    Wilmslow Way Handforth
    SK9 3PE Wilmslow
    Total Health Exercise Hydrotherapy &
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Rehabilitation Centre Ltd
    Wilmslow Way Handforth
    SK9 3PE Wilmslow
    Total Health Exercise Hydrotherapy &
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNone138641190001
    JACKSON, Jonathan Harvey
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Secrétaire
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    British65565290002
    PEERS, John Brian
    Springfield, 19 Chester Road
    Sutton Weaver
    WA7 3EE Runcorn
    Cheshire
    Secrétaire
    Springfield, 19 Chester Road
    Sutton Weaver
    WA7 3EE Runcorn
    Cheshire
    British88448730001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FORTUNE, Andrew Robert
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director91852420001
    HALLWORTH, Graham
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    EnglandBritishCompany Director153831820001
    JACKSON, Jonathan Harvey
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director65565290002
    JOHNSON, Robin Gardner
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director99321940001
    PEARSON, James Lee
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director185162450001
    PEERS, John Brian
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    Administrateur
    Wilmslow Way, Handforth
    Wilmslow
    SK9 3PE Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant88448730001
    WILLERS, Peter Alan
    Ballagawne Farm
    Garwick
    IM4 6EP Lonan
    Isle Of Man
    Administrateur
    Ballagawne Farm
    Garwick
    IM4 6EP Lonan
    Isle Of Man
    BritishBarrister61606290001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0