WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED

WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEST PARK TRADING CO.214 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04729269
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Rubicon
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 nov. 2017

    LRESSP

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 047292690005

    1 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 047292690005 en totalité

    1 pagesMR04

    État du capital après une attribution d'actions au 24 oct. 2017

    • Capital: GBP 7,806,612
    3 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2017

    17 pagesAA

    Modification des détails de Enserve Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 avr. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 159 Huddersfield Road Oldham OL1 3PA England à C/O Rubicon 8-12 York Gate London NW1 4QG le 09 juin 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Andrew John Chadwick en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Ashwood Court Springwood Way Tytherington Business Park Macclesfield Cheshire SK10 2XF à 159 Huddersfield Road Oldham OL1 3PA le 07 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Statuts

    7 pagesMA

    Cessation de la nomination de David Lee Cruddace en tant que directeur le 06 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Christopher Humphreys en tant que directeur le 06 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Darrell Fox en tant que secrétaire le 06 déc. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Christopher Humphreys en tant que secrétaire le 06 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Darrell Fox en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Mark Perkins en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    État du capital après une attribution d'actions au 09 nov. 2016

    • Capital: GBP 1,148,682
    4 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2016

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOX, Darrell
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    Secrétaire
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    220944120001
    FISCHER, Andrew Olaf
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    Administrateur
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    United KingdomGermanDirector70312740036
    FISHER, Ian
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    Administrateur
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    United KingdomBritishDirector51776160030
    FOX, Darrell
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    Administrateur
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    EnglandBritishAccountant56378250001
    PERKINS, Mark
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    Administrateur
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    EnglandBritishDirector85890200002
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    Administrateur
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon
    England
    EnglandBritishDirector118293300001
    HUMPHREYS, David Christopher
    Springwood Way
    Tytherington Business Park
    SK10 2XF Macclesfield
    Ashwood Court
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Springwood Way
    Tytherington Business Park
    SK10 2XF Macclesfield
    Ashwood Court
    Cheshire
    England
    173816220001
    JOHNSTONE, Lee
    Victoria Road
    Morley
    LS27 7PA Leeds
    Wellfield House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Victoria Road
    Morley
    LS27 7PA Leeds
    Wellfield House
    United Kingdom
    157001520001
    JOHNSTONE, Lee
    16 Mulberry Way
    Northowram
    HX3 7WJ Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Mulberry Way
    Northowram
    HX3 7WJ Halifax
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant105435350001
    KERSHAW, Christopher Graham
    7 Evesham Grove
    Idle
    BD10 8TN Bradford
    Secrétaire
    7 Evesham Grove
    Idle
    BD10 8TN Bradford
    BritishAccountant63085680001
    MORTON, Julia Alison
    Kingsdown Close
    Wychwood Park
    CW2 5FX Weston
    5
    Cheshire
    Secrétaire
    Kingsdown Close
    Wychwood Park
    CW2 5FX Weston
    5
    Cheshire
    British141157110001
    O'SULLIVAN, Liam
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    165553810001
    RAWCLIFFE AND CO. FORMATIONS LIMITED
    West Park House
    7-9 Wilkinson Avenue
    FY3 9XG Blackpool
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    West Park House
    7-9 Wilkinson Avenue
    FY3 9XG Blackpool
    Lancashire
    900017540001
    CHADWICK, Andrew John
    Huddersfield Road
    OL1 3PA Oldham
    159
    England
    Administrateur
    Huddersfield Road
    OL1 3PA Oldham
    159
    England
    United KingdomBritishAccountant105739410001
    CRUDDACE, David Lee, Mr.
    Springwood Way
    Tytherington Business Park
    SK10 2XF Macclesfield
    Ashwood Court
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Springwood Way
    Tytherington Business Park
    SK10 2XF Macclesfield
    Ashwood Court
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector165544960001
    HUMPHREYS, David Christopher
    Springwood Way
    Tytherington Business Park
    SK10 2XF Macclesfield
    Ashwood Court
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Springwood Way
    Tytherington Business Park
    SK10 2XF Macclesfield
    Ashwood Court
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director117192120002
    JOHNSTONE, Lee
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector105435350001
    KERSHAW, Christopher Graham
    7 Evesham Grove
    Idle
    BD10 8TN Bradford
    Administrateur
    7 Evesham Grove
    Idle
    BD10 8TN Bradford
    BritishAccountant63085680001
    LEACH, William Anthony
    Highercroft 135 Turton Road
    Tottington
    BL8 4AJ Bury
    Lancashire
    Administrateur
    Highercroft 135 Turton Road
    Tottington
    BL8 4AJ Bury
    Lancashire
    EnglandBritishManaging Director105740390001
    LIGHTOWLERS, Oliver James
    2 Goldsborough Court
    Church Street
    HG5 8AP Goldsborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    2 Goldsborough Court
    Church Street
    HG5 8AP Goldsborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant156531690001
    OWENS, David William
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Shenley Road
    WD6 1TE Borehamwood
    Hertsmere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector110731260001
    RIGBY, William Simon
    Springwood
    Scotchman Lane Morley
    LS27 0NZ Leeds
    Yorkshire
    Administrateur
    Springwood
    Scotchman Lane Morley
    LS27 0NZ Leeds
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector48515290001
    TATE, Wendy
    Wellfield House
    Victoria Road Morley
    LS27 7PA Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wellfield House
    Victoria Road Morley
    LS27 7PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector103094250002
    RAWCLIFFE AND CO. COMPANY SERVICES LIMITED
    West Park House
    7/9 Wilkinson Avenue
    FY3 9XG Blackpool
    Lancashire
    Administrateur désigné
    West Park House
    7/9 Wilkinson Avenue
    FY3 9XG Blackpool
    Lancashire
    900013030001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon, 8-12
    England
    06 avr. 2016
    York Gate
    NW1 4QG London
    C/O Rubicon, 8-12
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3250709
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2016
    Livré le 21 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    This accession relates to a debenture dated 30.12.2015 between (1) schultz parent limited, (2) schultz bidco limited and (3) hsbc corporate trustee company (UK) limited as security agent.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent
    Transactions
    • 21 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 oct. 2017Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 31 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 janv. 2011
    Livré le 27 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from spice PLC and each of its subsidiaries from time to time to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 juin 2003
    Livré le 05 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as iveridge hall wakefield road oulton leeds t/n wyk 611215 and t/n wyk 611221. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 avr. 2003
    Livré le 22 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WEST PARK TRADING CO.214 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 nov. 2017Commencement of winding up
    05 juil. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    practitioner
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0