THE TRIBAL GROUP FOUNDATION
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE TRIBAL GROUP FOUNDATION |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 04730598 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE TRIBAL GROUP FOUNDATION ?
| Adresse du siège social | Kings Orchard Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE TRIBAL GROUP FOUNDATION ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 15 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Kyle Mcgrath en tant que directeur le 25 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Martin Cumella en tant que directeur le 25 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kyle Mcgrath en tant que directeur le 25 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Beveridge en tant que directeur le 25 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Beveridge en tant que directeur le 25 avr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 19 pages | AA | ||
Nomination de Mr Mark Pickett en tant qu'administrateur le 18 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Derrick Breach en tant que directeur le 18 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Keith Martin Evans en tant que directeur le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2016 sans liste des membres | 6 pages | AR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 11 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2015 sans liste des membres | 6 pages | AR01 | ||
Cessation de la nomination de Clive Roderic Ansell en tant que directeur le 30 juin 2014 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 11 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Derrick Breach le 05 juin 2014 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR à Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ le 04 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2014 sans liste des membres | 8 pages | AR01 | ||
Qui sont les dirigeants de THE TRIBAL GROUP FOUNDATION ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKETT, Mark Jeremy | Administrateur | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | England | British | 210493320001 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Secrétaire | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | British | 53398040001 | ||||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Secrétaire | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | 150940560001 | |||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Secrétaire | 28 Henleaze Avenue BS9 4ET Bristol Avon | British | 68807890001 | ||||||
| ALEXANDER, Catherine | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 137531720001 | |||||
| ALI, Lutfur Rahman | Administrateur | 28 Battery Road SE28 0JL London | British | 107803090001 | ||||||
| ANSELL, Clive Roderic | Administrateur | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 297900880001 | |||||
| BENTON, Anthony Henley | Administrateur | The Leys Hoxne IP21 5BP Eye Suffolk | United Kingdom | British | 75082440001 | |||||
| BEVERIDGE, Richard | Administrateur | Barton Road LA1 4ER Lancaster 14 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 129927540001 | |||||
| BREACH, Stephen Derrick | Administrateur | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 174695940001 | |||||
| COLLINS, Helen Victoria | Administrateur | 91a Castlecroft Road Finchfield WV3 8BY Wolverhampton | United Kingdom | British | 85146140002 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 53398040001 | |||||
| CORY, Alistair | Administrateur | 142 Divinity Road OX4 1LR Oxford Oxfordshire | British | 82256690001 | ||||||
| CUMELLA, Martin | Administrateur | Wood End Lodge Poolhead Lane, Tamworth In Arden BG4 5ED Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 71794750002 | |||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 155012210001 | |||||
| EVANS, Keith Martin, Dr | Administrateur | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 83582830002 | |||||
| FRAZER, Robert Michael | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Northern Ireland | Northern Irish | 134047440001 | |||||
| GILHEANY, Peter | Administrateur | 27 Harlescott Road SE15 3DA London | United Kingdom | British | 114194370001 | |||||
| GOOD, Martin Edward | Administrateur | 29 Fulbrooke Road CB3 9EE Cambridge | United Kingdom | British | 11362040002 | |||||
| HARRIS, Karen Fiona | Administrateur | 21 Newcombe Park Mill Hill NW7 3QN London Nw7 3qn | British | 58173890001 | ||||||
| KETTLEWELL, Andrew Michael | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Rwanda | British | 155012620001 | |||||
| LAWTON, Simon Marcus | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 68807890001 | |||||
| LUCHMUN, Samatha | Administrateur | Portland Square BS2 8RR Bristol 1-4 United Kingdom | United Kingdom | British | 154378940001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 176044430001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Administrateur | Vine Cottage 48 High Street RG10 8BY Wangrove Berkshire | England | British | 176044430001 | |||||
| MCGRATH, Kyle | Administrateur | 23 Millmount Road S8 9EG Sheffield | United Kingdom | British | 114191290001 | |||||
| MIDDLETON, George | Administrateur | High Close House NE41 8BL Wylam . Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 129929830001 | |||||
| NOEL, Elizabeth Mary Alice | Administrateur | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | British | 95923090001 | ||||||
| PITMAN, Henry John | Administrateur | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 55231490005 | |||||
| RICKATSON, Caroline | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Scotland | British | 155008870001 | |||||
| TRICKETT, Christopher | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 150933510001 | |||||
| TRIEU, Nuong | Administrateur | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 154371400001 | |||||
| VISICK, Sarah Jane | Administrateur | 14 Gander Hill RH16 1QX Haywards Heath West Sussex | England | British | 122751160001 | |||||
| WYNNE-JONES, Amy Elizabeth | Administrateur | Portland Square BS2 8RR Bristol 1-4 United Kingdom | United Kingdom | British | 154371180001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE TRIBAL GROUP FOUNDATION ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribal Group Plc | 01 déc. 2016 | Kings Orchard One Queen Street BS2 0HQ Bristol Kings Orchard Bristol United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
THE TRIBAL GROUP FOUNDATION a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 14 juin 2007 Livré le 21 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0