EDITION HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEDITION HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04731815
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EDITION HOMES LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe EDITION HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EDITION HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROCKHILL HOMES LIMITED16 mai 200316 mai 2003
    WILLOUGHBY (430) LIMITED11 avr. 200311 avr. 2003

    Quels sont les derniers comptes de EDITION HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EDITION HOMES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EDITION HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2016

    9 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    9 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2015

    10 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    7 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Paul John Construction Ltd Telford Way Stephenson Industrial Estate Coalville Leicestershire LE67 3HE United Kingdom* le 20 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 avr. 2013

    État du capital au 12 avr. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2012 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 22 oct. 2012

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 06 juin 2012

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Scott Davidson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark David Poulson en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Twomlow en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Twomlow en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 4Th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS* le 18 janv. 2012

    1 pagesAD01

    legacy

    2 pagesLQ01

    legacy

    4 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de EDITION HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    POULSON, Mark David
    Oldfield Lane
    Rothley
    LE7 7QD Leicester
    3
    England
    Secrétaire
    Oldfield Lane
    Rothley
    LE7 7QD Leicester
    3
    England
    168568800001
    HENRY, John Timothy
    The Hovel
    Spinney Drive Kirby Grange
    LE9 9FG Botcheston
    Leicestershire
    Administrateur
    The Hovel
    Spinney Drive Kirby Grange
    LE9 9FG Botcheston
    Leicestershire
    EnglandBritish161954590001
    BROUDER, John Francis
    149 Scraptoft Lane
    LE5 2FF Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    149 Scraptoft Lane
    LE5 2FF Leicester
    Leicestershire
    British16306630001
    MCEWAN, Keith
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    British9631320003
    TWOMLOW, David John
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    Secrétaire
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    British50893390001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire désigné
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    900023630001
    BAGSHAW, Paul William Richard
    Rotherhill
    1 Church Lane Spoxton
    LE14 4PZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Rotherhill
    1 Church Lane Spoxton
    LE14 4PZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritish75614770001
    DAVIDSON, Scott Innes
    Bottom Green Farm
    Bottom Green, Upper Broughton
    LE14 3BA Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Bottom Green Farm
    Bottom Green, Upper Broughton
    LE14 3BA Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish31525750002
    TWOMLOW, David John
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    Administrateur
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    EnglandBritish50893390001
    WOOD, Timothy John
    Magnolia Cottage
    Green Lane Off Cockshot Lane
    WR7 4JZ Dormston
    Worcestershire
    Administrateur
    Magnolia Cottage
    Green Lane Off Cockshot Lane
    WR7 4JZ Dormston
    Worcestershire
    United KingdomBritish104447140001
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur désigné
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    900023620001

    EDITION HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 08 oct. 2010
    Livré le 15 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the debtor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H residential flats at hamilton fields hamilton leicester t/n LT416636 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 113 juin 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 125 oct. 2012Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2009
    Livré le 06 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property being flats VT4 four chimneys crescent hampton vale peterborough, t/no.CB339582 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sol Construction Limited
    Transactions
    • 06 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of rental income
    Créé le 21 juil. 2009
    Livré le 23 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assets and all rights under or in relation to the rental income and all claims relating to them see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 2009
    Livré le 15 juin 2009
    En cours
    Montant garanti
    £241,695 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    L/H land and premises k/a flats at V2 stewartby avenue, hampton vale, petersborough t/no CB339586.
    Personnes ayant droit
    • Clegg Accomodation Solutions Limited
    Transactions
    • 15 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over deposit
    Créé le 09 janv. 2009
    Livré le 14 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the entire right, title and interest in and to all money in any currency standing to the credit of the account numbered 0631855, sort code: 12-08-81 and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 2009
    Livré le 13 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a first and second floors VT2 hampton vale peterborough fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 206 déc. 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 2009
    Livré le 13 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a first and second floors VT4 hampton vale peterborough fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 306 déc. 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 3
    Charge of agreement for lease
    Créé le 12 oct. 2007
    Livré le 18 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from henry davidson developments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An agreement for lease dated 15 august 2007 relating to residential flats at the local centre off sandhills avenue, hamilton, leicester part t/no LT390439 and all money now and in the future due to the company pursuant to the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Charge of agreement for lease
    Créé le 10 oct. 2007
    Livré le 13 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from henry davidson developments LTD (the debtor) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An agreement for lease dated 25 july 2007 relating to residential flats at the local centre hampton vale peterborough and made between (1) the debtor) and (2) the company and all money due pursuant to the agreement.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 août 2007
    Livré le 25 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 25 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EDITION HOMES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gregory Bill Judd
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    receiver manager
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Alistair Charles Wright
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    receiver manager
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan Edward Cookson
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    receiver manager
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    R Crompton
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    receiver manager
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan Edward Cookson
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    receiver manager
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    R Crompton
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    receiver manager
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    4
    DateType
    09 janv. 2014Commencement of winding up
    29 avr. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Paul James Goodwin
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    practitioner
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0